THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC301153
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Indirizzo della sede legale
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    3 pagineLLDS01

    Cessazione della carica di Paul Graham Wiltshire come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Simon Francis Winn come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Iestyn Milton Williams come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Rhoderick Peter Whitbread come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Lewis Fitzgerald Watts come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Nigel Jeremy Webb come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Garry Tibbott Veale come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Walter Henry Rupert Wilkes come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Stephen William Vaughan come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Julian Usher come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Katherine Isobel Mary Sanders come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Martin Philip Trees come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Paul Smith come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Neil Douglas Smith come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Lance Clifford Redfern Smith come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Werner Schuenemann come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Trudi Ometha Ryan Dawes come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Peter John Rowlins come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Daman Marcus Sanders come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Christine Louise Marina Ross come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Peter Bernard Robson come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Stuart Godfrey Popham come socio in data 01 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Chi sono gli amministratori di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4244204
    141180020001
    ANDREW, Jonathan
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    Socio di LLP
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    England88713160003
    BALZER, Doris
    154 Ashley Gardens
    Thirleby
    SW1P 1HW London
    Socio di LLP
    154 Ashley Gardens
    Thirleby
    SW1P 1HW London
    United Kingdom141222510001
    BARNES, Simon Seton
    Frienden Farm
    Moat Lane Chiddingstone Hoath
    TN8 7DN Edenbridge
    Socio di LLP
    Frienden Farm
    Moat Lane Chiddingstone Hoath
    TN8 7DN Edenbridge
    England138395230001
    BEST, Anthony John
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    Socio di LLP
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    United Kingdom141213930001
    BLACKMAN, Carmela Louisa
    Warren Yard
    Wolverton Mill
    MK12 5NW Milton Keynes
    3
    England
    Socio di LLP
    Warren Yard
    Wolverton Mill
    MK12 5NW Milton Keynes
    3
    England
    England19845460001
    BRADLEY, Carolyn Jane
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    1
    England
    Socio di LLP
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    1
    England
    United Kingdom71314040004
    BROOKES, Martin
    Fairbridge Road
    N19 3EW London
    39
    England
    Socio di LLP
    Fairbridge Road
    N19 3EW London
    39
    England
    United Kingdom141222180005
    BULL, Ian Alan
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    Socio di LLP
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    England210299090001
    CAKEBREAD, Stuart Alan Charles
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    Socio di LLP
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    United Kingdom141213960001
    CASTIAU, Jain Anne
    Marine Parade
    CT5 2BQ Whitstable
    6
    Kent
    England
    Socio di LLP
    Marine Parade
    CT5 2BQ Whitstable
    6
    Kent
    England
    United Kingdom78256720003
    CHALK, John William
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    Socio di LLP
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    United Kingdom74739180015
    CLOWES, David James Leonard
    54 Heathview
    Gordon House Road
    NW5 1LR London
    Socio di LLP
    54 Heathview
    Gordon House Road
    NW5 1LR London
    United Kingdom36989810001
    CRAWFORD, Philip James
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    Socio di LLP
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    England61146460001
    DANIEL, George Edward
    Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Burwood Lodge
    Kent
    Socio di LLP
    Oak Lane
    TN13 1UF Sevenoaks
    Burwood Lodge
    Kent
    United Kingdom141222400002
    DONNELLY, Mal
    Fieldings
    Berry Lane
    MK17 8HS Aspley Guise
    Socio di LLP
    Fieldings
    Berry Lane
    MK17 8HS Aspley Guise
    United Kingdom74225620001
    DOOTSON, David Philip
    Finlow Hill Lane
    Over Alderley
    SK10 4UG Macclesfield
    Finlow Hill
    Cheshire
    England
    Socio di LLP
    Finlow Hill Lane
    Over Alderley
    SK10 4UG Macclesfield
    Finlow Hill
    Cheshire
    England
    United Kingdom222661330001
    DWYER, Tonianne
    Castle Street
    4103 Fairfield
    20
    Queensland
    Australia
    Socio di LLP
    Castle Street
    4103 Fairfield
    20
    Queensland
    Australia
    Australia141222160004
    DYSON, Arthur John
    Cambridge Street
    SW1V 4QQ London
    60
    England
    Socio di LLP
    Cambridge Street
    SW1V 4QQ London
    60
    England
    United Kingdom141222710006
    FRANGAKIS, Athanassios
    4 Hillside Close
    NW8 0EF London
    Socio di LLP
    4 Hillside Close
    NW8 0EF London
    United Kingdom32310140001
    GIBSON, Peter John Bradford
    Great Bardfield Hall
    Great Bardfield
    CM7 4RZ Braintree
    Socio di LLP
    Great Bardfield Hall
    Great Bardfield
    CM7 4RZ Braintree
    United Kingdom141222440001
    GRASSO, Luigi
    Hyde Park Square
    W2 2LU London
    14
    England
    Socio di LLP
    Hyde Park Square
    W2 2LU London
    14
    England
    United Kingdom141213770003
    GRAY, Duncan Cameron
    Clandon Road
    GU4 7UW West Glandon
    Haven House
    Socio di LLP
    Clandon Road
    GU4 7UW West Glandon
    Haven House
    United Kingdom141222560003
    GREEN, Philip
    4 Denewood Road
    N6 4AJ London
    Socio di LLP
    4 Denewood Road
    N6 4AJ London
    England30316150004
    GWYN JONES, Timothy
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Socio di LLP
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    United Kingdom48297190002
    HALE, Graham
    Graythwaite
    Barrow Lane
    WA15 0DL Hale
    Socio di LLP
    Graythwaite
    Barrow Lane
    WA15 0DL Hale
    England16807130001
    HANSON, Ian Lawrence
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SI7 2DH Marlow
    Socio di LLP
    House On The Hill
    Beechwood Drive
    SI7 2DH Marlow
    United Kingdom99645000001
    HARRIS, George
    6 Clonway
    PL20 6EG Yelverton
    Socio di LLP
    6 Clonway
    PL20 6EG Yelverton
    United Kingdom3087310001
    HARTWELL, Andrew James
    57 Corringham Road
    NW11 7BS London
    Socio di LLP
    57 Corringham Road
    NW11 7BS London
    United Kingdom141222530001
    HAYEEM, Marc
    4 Royce Grove
    WD25 7GD Leavesden
    Socio di LLP
    4 Royce Grove
    WD25 7GD Leavesden
    United Kingdom77750110001
    HENMAN, Timothy Henry
    Filberts
    Aston Tirrold
    OX11 9DY Didcot
    Socio di LLP
    Filberts
    Aston Tirrold
    OX11 9DY Didcot
    United Kingdom141222230001
    HERBERT, Richard David Standish
    Forty Green Road
    HP9 1XS Beaconsfield
    Orchard Cottage
    Socio di LLP
    Forty Green Road
    HP9 1XS Beaconsfield
    Orchard Cottage
    England141222460001
    HOLDEN, Gary
    62 Paper Mill Wharf
    50 Narrow Street Limehouse
    E14 8BZ London
    Socio di LLP
    62 Paper Mill Wharf
    50 Narrow Street Limehouse
    E14 8BZ London
    United Kingdom78011050001
    HUGHES, Colin Norman
    Chaithanya Smaran
    Kannamangala Main Road
    Whitefield
    R-108
    Bangalore 560067
    India
    Socio di LLP
    Chaithanya Smaran
    Kannamangala Main Road
    Whitefield
    R-108
    Bangalore 560067
    India
    United Kingdom141222210002

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    23 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.6, LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over assets
    Creato il 01 ago 2002
    Consegnato il 05 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account, the right to demand the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sociiti Ginirale
    Transazioni
    • 05 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 28 giu 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over all right,title and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each dedicated account and the debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Pledge and chage
    Creato il 03 mag 2002
    Consegnato il 09 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over the rights and interests of parties to the existing agreements; by way of pledge of thge delivery material relating to the tv programmes entitled "ncs manhunt - series 2","the secret" and "man & boy". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centre House Productions Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Pledge and charge
    Creato il 16 apr 2002
    Consegnato il 26 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to sg leasing (march) limited (sglm) and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the chargor's right title and interest in and to the rights. By way of pledge of the delivery material (the original picture negative and other physical materials and documentation relating to the television programmes entitled "born and bred" (aka "heart of the valley") and "murder in mind" series 2 episodes 3-6). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centre House Productions Limited
    Transazioni
    • 26 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 16 apr 2002
    Consegnato il 17 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and nterest in and to the security assignment please refer to form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 17 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 27 mar 2002
    Consegnato il 04 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole and every part of its right title and interest in and to the security assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 04 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 28 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee, as security for the payment, discharge and performance of all secured liabilities; charges to the chargee by way of first fixed charge (a) the whole and every part of its right, title and interest in and to the security assignment;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0