THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP

THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC304608
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Dove si trova THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP?

    Indirizzo della sede legale
    C/O CORK GULLY LLP
    40 Villiers Street
    WC2N 6NJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al04 apr 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il04 gen 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2015

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al06 mag 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma20 mag 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    13 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    14 pagineWU07

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Cork Gully Llp 6 Snow Hill London EC1A 2AY a 40 Villiers Street London WC2N 6NJ in data 15 mag 2024

    3 pagineLLAD01

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    14 pagineWU07

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Certificate of appointment of liquidator by Secretary of State
    1 pagineLIQ MISC

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor Unit 19, Tileyard Studios Tileyard Road London N7 9AH a C/O Cork Gully Llp 6 Snow Hill London EC1A 2AY in data 25 mag 2022

    2 pagineLLAD01

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Cessazione della carica di Robin Leonard Henshall come socio in data 30 gen 2020

    2 pagineLLTM01

    Modifiche ai dati del socio per Mr Simon James Moran in data 30 mag 2019

    2 pagineLLCH01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2016

    121 pagineLLAR01

    Modifiche ai dati del socio per Mr Jonathan Marx Laredo in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Mr Jonathan Marx Laredo in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Benedict Patrick Wisden in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Simon Victor Clough in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Benedict Patrick Wisden in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Shahab Guilanpour in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Simon Victor Clough in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Shahab Guilanpour in data 06 mag 2016

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Mr Michael Coatman in data 31 mar 2016

    3 pagineLLCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 05 apr 2015

    4 pagineAA

    Modifiche ai dati del socio per Kenan Altunis in data 10 dic 2015

    2 pagineLLCH01

    Modifiche ai dati del socio per Kenan Altunis in data 10 dic 2015

    2 pagineLLCH01

    Chi sono gli amministratori di THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LWF ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Vantis Group
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Socio designato di LLP
    Vantis Group
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    141261230001
    LWF MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Vantis Group
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Socio designato di LLP
    Vantis Group
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    141261240001
    ADAMS, Michael Richard
    37 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    Socio di LLP
    37 The Woodlands
    LE16 7BW Market Harborough
    England89659810001
    ADAMS, Peter Robert Noel
    Nymet Rowland
    EX17 6AL Crediton
    The Old Rectory
    Devon
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Nymet Rowland
    EX17 6AL Crediton
    The Old Rectory
    Devon
    United Kingdom
    3654930002
    AINSCOW, Carol Ann
    Shorefield House
    Dunscar Fold Dunscar
    BL7 9DE Bolton
    Socio di LLP
    Shorefield House
    Dunscar Fold Dunscar
    BL7 9DE Bolton
    United Kingdom158172740001
    ALLARDYCE, Samuel
    2 Long Meadow
    Bromley Cross
    BL7 9YH Bolton
    Lancashire
    Socio di LLP
    2 Long Meadow
    Bromley Cross
    BL7 9YH Bolton
    Lancashire
    England27921090001
    ALTUNIS, Kenan
    19 Church Road
    BN3 2FA Hove
    Palmeira Avenue Mansions
    East Sussex
    Socio di LLP
    19 Church Road
    BN3 2FA Hove
    Palmeira Avenue Mansions
    East Sussex
    England141433300004
    AMATO, Keith Anthony
    Highmead, Spring Elms Lane
    Little Baddow
    CM3 4SQ Chelmsford
    Socio di LLP
    Highmead, Spring Elms Lane
    Little Baddow
    CM3 4SQ Chelmsford
    England141432930001
    ANDERSON, Elke Annette
    Links Road
    GU5 0AL Bramley
    Ashley Lodge
    Surrey
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Links Road
    GU5 0AL Bramley
    Ashley Lodge
    Surrey
    United Kingdom
    United Kingdom141441510006
    ARNOTT, Andrew George David
    Baddiley House
    Church Hill Merstham
    RH1 3BJ Redhill
    Socio di LLP
    Baddiley House
    Church Hill Merstham
    RH1 3BJ Redhill
    United Kingdom141421880001
    ATHA, Charles Anthony Stewart
    West End House, 8 West End
    Stokesley
    TS9 5BN Middlesbrough
    Socio di LLP
    West End House, 8 West End
    Stokesley
    TS9 5BN Middlesbrough
    England141344830001
    ATTIAS, Timothy Levi Perryman
    10 Randolph Road
    W9 1AN* London
    Socio di LLP
    10 Randolph Road
    W9 1AN* London
    United Kingdom141433650001
    BALL, Andrew John
    6 Regent Drive
    Lostock
    BL6 4DH Bolton
    Socio di LLP
    6 Regent Drive
    Lostock
    BL6 4DH Bolton
    United Kingdom141438600001
    BARTON, Justin Glenn
    2 Stevenage Road
    Fulham
    SW6 6ER London
    Socio di LLP
    2 Stevenage Road
    Fulham
    SW6 6ER London
    England42636200002
    BEATTLE, Michael John
    110 Pekoe Court
    Cardamom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    Socio di LLP
    110 Pekoe Court
    Cardamom Building 31 Shad Thames
    SE1 2YR London
    141433410001
    BEESTON, Bryan Edward
    Arnewood Corner
    Linnies Lane, Sway
    SO41 6ER Hampshire
    Socio di LLP
    Arnewood Corner
    Linnies Lane, Sway
    SO41 6ER Hampshire
    England21726140005
    BLAKEY, Graeme David
    Clanburgh
    Manor Road, Caunton
    NG23 6AD Newark
    Socio di LLP
    Clanburgh
    Manor Road, Caunton
    NG23 6AD Newark
    United Kingdom34001190003
    BOND, Rod
    Ravenstone House
    Britannia Road
    M33 2NN Sale
    Socio di LLP
    Ravenstone House
    Britannia Road
    M33 2NN Sale
    141438630001
    BOSCAWEN, Evelyn Arthur Hugh, Viscount
    Tregothnan
    TR2 4AN Truro
    Socio di LLP
    Tregothnan
    TR2 4AN Truro
    England6747110005
    BOULTON, Andrew William John
    Silverless Street
    SN8 1JQ Marlborough
    8
    Wiltshire
    Socio di LLP
    Silverless Street
    SN8 1JQ Marlborough
    8
    Wiltshire
    United Kingdom141423750002
    BOWEN, Christopher Richard Croasdaile
    IV14 9ET Strathpenffen
    Kinellan House
    Ross-Shire
    Socio di LLP
    IV14 9ET Strathpenffen
    Kinellan House
    Ross-Shire
    United Kingdom55182800001
    BROOKSBANK, John Stephen
    Field Bottom Farm
    Coley Road Shelf
    HX3 7SA Halifax
    Socio di LLP
    Field Bottom Farm
    Coley Road Shelf
    HX3 7SA Halifax
    England63274570016
    BURRELL, Paul
    Church View
    High Street, Farndon
    CH3 6PT Chester
    Socio di LLP
    Church View
    High Street, Farndon
    CH3 6PT Chester
    United Kingdom141438790001
    CHUNILAL, Damian
    Mount Austin Road
    The Peak
    Hong Kong
    22b
    Socio di LLP
    Mount Austin Road
    The Peak
    Hong Kong
    22b
    141433560002
    CLOUGH, Simon Victor
    The Crescent
    Barnes Village
    SW13 0NN London
    29
    United Kingdom
    Socio di LLP
    The Crescent
    Barnes Village
    SW13 0NN London
    29
    United Kingdom
    United Kingdom13027200004
    COATMAN, Michael
    242 Newchurch Road
    BB4 7QX Rossendale
    Springfield House
    Lancashire
    England
    Socio di LLP
    242 Newchurch Road
    BB4 7QX Rossendale
    Springfield House
    Lancashire
    England
    England122831040003
    COOPER, Alistair Willis Peter
    Sydling Estate, Upper Sydling House
    Upsydling
    DT2 9PH Dorchester
    Socio di LLP
    Sydling Estate, Upper Sydling House
    Upsydling
    DT2 9PH Dorchester
    141438470001
    CORNE, Richard
    Pickade House
    Risborough Road, Great Kimble
    HP17 0XS Aylesbury
    Socio di LLP
    Pickade House
    Risborough Road, Great Kimble
    HP17 0XS Aylesbury
    England141423560001
    COWEN, Robert Ian
    4 Green Acres
    Hunton
    DL8 1QZ Bedale
    Socio di LLP
    4 Green Acres
    Hunton
    DL8 1QZ Bedale
    United Kingdom21671190001
    COWGILL, Peter Alan
    14 The Hamlet
    High Bank Lane Off Chorley New Road
    BL6 4QT Bolton
    Socio di LLP
    14 The Hamlet
    High Bank Lane Off Chorley New Road
    BL6 4QT Bolton
    United Kingdom84147460001
    CRONK, Michael Anthony Justin
    11 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    Socio di LLP
    11 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    United Kingdom45166580001
    DRAKE, John Christopher
    Rue De Villers
    20/3 Bruxells 1000
    Belgium
    Socio di LLP
    Rue De Villers
    20/3 Bruxells 1000
    Belgium
    141433610001
    EARL OF YARBOROUGH, Charles John, Rt Hon
    Brocklesby Park
    DN41 8FB Grimsby
    Socio di LLP
    Brocklesby Park
    DN41 8FB Grimsby
    England141429250001
    EASTERBY, Timothy David
    Whiteholme Farm
    Great Habton
    YO17 6TY Malton
    Socio di LLP
    Whiteholme Farm
    Great Habton
    YO17 6TY Malton
    England10509900001
    ELLIOTT, Robert Tregellas
    The Gables
    Hervines Road
    HP6 5HS Amersham
    Buckinghamshire
    Socio di LLP
    The Gables
    Hervines Road
    HP6 5HS Amersham
    Buckinghamshire
    England5332810006

    THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over bank account and deposit
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 19 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in to the account being account number 29267905 and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 19 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over bank account and deposit
    Creato il 30 mar 2006
    Consegnato il 19 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in to the account being account number 28154490 and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 19 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)

    THE FILM DEVELOPMENT PARTNERSHIP II LLP ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 mag 2021Data della petizione
    15 dic 2021Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Southend
    2nd Floor Alexander House 21 Victoria Avenue
    SS99 1AA Southend On Sea
    Essex
    Praticante
    2nd Floor Alexander House 21 Victoria Avenue
    SS99 1AA Southend On Sea
    Essex
    Stephen Robert Leslie Cork
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Anthony Malcolm Cork
    Cork Gully Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    Cork Gully Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0