THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC307299
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP?

    Indirizzo della sede legale
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio di micro-entità redatto al 05 apr 2022

    2 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    2 pagineLLDS01

    Cessazione della carica di Spiros Michael come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Diane Walton come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Robert John Llewellyn come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Rosalind Loveridge come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di David Joseph Chadwick come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di William George Lane come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Roy Johnson come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Robert Frances Raymond Joliffe come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Nigel James Yates come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Adrian Mark Williamson come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Paul Vallance come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Peter Lawrence Warne come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Gyles Turrell come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Peter Elisa Roos come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Philip George Walton come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Peter Gilhespy Willey come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Dorothy Rose Purdew come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Michael Robert Pedder come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Paul Harold Mackenzie Turner come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Rachana Thakrar come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Jacob Francois Smit come socio in data 08 mar 2022

    1 pagineLLTM01

    Chi sono gli amministratori di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4244204
    141180020001
    ADDISON, Richard John Julian
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Socio di LLP
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom141227350001
    ANIM, Justin Martyn
    29 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PN Newcastle Upon Tyne
    Socio di LLP
    29 Holly Avenue
    Jesmond
    NE2 2PN Newcastle Upon Tyne
    England141641850001
    BAMFORD, Niall Richard
    Worcester Road
    SM2 6PW Sutton
    Flat 7 The Firs 23
    England
    Socio di LLP
    Worcester Road
    SM2 6PW Sutton
    Flat 7 The Firs 23
    England
    England115337990009
    BATTERS, Raymond James
    Lyndhurst
    1 Upper Bar
    TF10 7EH Newport
    Socio di LLP
    Lyndhurst
    1 Upper Bar
    TF10 7EH Newport
    England24339740001
    BELL, Kirsty
    Sunniside East
    Killingworth Village
    NE12 6BL Newcastle Upon Tyne
    Socio di LLP
    Sunniside East
    Killingworth Village
    NE12 6BL Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom142381930001
    BINNS, Mark Andrew
    63 Rowley Lane
    Fenay Bridge
    HD8 0JG Huddersfield
    Socio di LLP
    63 Rowley Lane
    Fenay Bridge
    HD8 0JG Huddersfield
    United Kingdom42295350002
    BOYLAN, Stephen
    33 Prestwich Park Road South
    Prestwich
    M25 9PF Manchester
    Socio di LLP
    33 Prestwich Park Road South
    Prestwich
    M25 9PF Manchester
    United Kingdom141660390001
    BUSH, William George
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    Socio di LLP
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Ernst & Young Llp
    England141176110001
    CHADWICK, David Joseph
    Macclesfield Road
    SK9 7BL Alderley Edge
    Witch's Gate
    Socio di LLP
    Macclesfield Road
    SK9 7BL Alderley Edge
    Witch's Gate
    United Kingdom141654310002
    COTTAM, Gillian Jean Bird
    64 Moorcroft Road
    Moseley
    B13 8LU Birmingham
    Socio di LLP
    64 Moorcroft Road
    Moseley
    B13 8LU Birmingham
    United Kingdom141654850001
    COTTLE, Gary Steven
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    High Tong
    Kent
    Socio di LLP
    Marle Place Road
    TN12 7HS Brenchley
    High Tong
    Kent
    England141652020002
    COULSON, Shaun Christopher Craig
    Glebe House
    Church Road, Shedfield
    SO32 2HY Southampton
    Socio di LLP
    Glebe House
    Church Road, Shedfield
    SO32 2HY Southampton
    United Kingdom115830270001
    CROSS, Anthony Maurice
    Rock House
    Church Street, Clitheroe
    BB7 2DG Blackburn
    Socio di LLP
    Rock House
    Church Street, Clitheroe
    BB7 2DG Blackburn
    United Kingdom141654770001
    DHANDA, Alok
    Victoria Mews
    Jesmond
    NE2 1ER Newcastle Upon Tyne
    11
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Victoria Mews
    Jesmond
    NE2 1ER Newcastle Upon Tyne
    11
    United Kingdom
    United Kingdom141310640004
    DIXON, Paul William Henry
    Anlaby House Estate
    Beverley Road
    HU10 7AY Anlaby
    6 The Square
    East Yorkshire
    Socio di LLP
    Anlaby House Estate
    Beverley Road
    HU10 7AY Anlaby
    6 The Square
    East Yorkshire
    United Kingdom153357310001
    DIXON, Simon Timothy
    St Oswalds 2a Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    Socio di LLP
    St Oswalds 2a Main Street
    Hotham
    YO43 4UF York
    United Kingdom101291990002
    DOLIN, Simon John, Dr
    Piemans
    Bignor Lane
    RH20 1PG Bignor, West Sussex
    Socio di LLP
    Piemans
    Bignor Lane
    RH20 1PG Bignor, West Sussex
    England141654760001
    EBDON, Peter David
    Britannia Warehouse
    The Docks
    GL1 2EH Gloucester
    C/O Mazars Llp
    Gloucestershire
    Socio di LLP
    Britannia Warehouse
    The Docks
    GL1 2EH Gloucester
    C/O Mazars Llp
    Gloucestershire
    United Kingdom141461130001
    EDWARDS, John Brynmor
    Yarnscombe
    EX31 3LW Barnstaple
    Bowling Green Farm
    England
    Socio di LLP
    Yarnscombe
    EX31 3LW Barnstaple
    Bowling Green Farm
    England
    United Kingdom82287680003
    ESPREY, Antony Michael, Dr
    1a Hall Place Drive
    KT13 0AJ Weybridge
    Socio di LLP
    1a Hall Place Drive
    KT13 0AJ Weybridge
    England141660270001
    EVANGELI, Christopher
    121 A Top Floor Kenton Road
    HA3 0AZ Harrow
    Socio di LLP
    121 A Top Floor Kenton Road
    HA3 0AZ Harrow
    United Kingdom141386100001
    EVANGELI, Nicholas
    5 Elmwood Avenue
    Kenton
    HA3 8AJ Harrow
    Socio di LLP
    5 Elmwood Avenue
    Kenton
    HA3 8AJ Harrow
    England141386110001
    EVANS, Rodley
    5 Hawthorne Drive
    The Bryn, Pontllanfraith
    NP12 2PP Blackwood
    Gwent
    Socio di LLP
    5 Hawthorne Drive
    The Bryn, Pontllanfraith
    NP12 2PP Blackwood
    Gwent
    United Kingdom53065220001
    FEARON, Andrew Jason
    Brooms
    Langley Lower Green
    CB11 4SB Saffron Walden
    Socio di LLP
    Brooms
    Langley Lower Green
    CB11 4SB Saffron Walden
    United Kingdom69281370002
    FOGG, Anthony John Blakeley
    Thorn Hanger
    The Common
    SN8 1DL Marlborough
    Socio di LLP
    Thorn Hanger
    The Common
    SN8 1DL Marlborough
    England141654120001
    FRANCKEISS, Anton, Doctor
    Wensley Road
    HG2 8AQ Harrogate
    11
    West Yorkshire
    England
    Socio di LLP
    Wensley Road
    HG2 8AQ Harrogate
    11
    West Yorkshire
    England
    United Kingdom141607160002
    FREEMAN, Christopher Thomas
    Coley Avenue
    GU22 7BS Woking
    Radbourne
    England
    Socio di LLP
    Coley Avenue
    GU22 7BS Woking
    Radbourne
    England
    United Kingdom141663460002
    GABBIE, Roy Anthony
    Ten Acre Rappax Road
    Hale
    WA15 0NT Altrincham Cheshire
    Socio di LLP
    Ten Acre Rappax Road
    Hale
    WA15 0NT Altrincham Cheshire
    United Kingdom106771780001
    GREAVES, Irena
    Forum Magnum Square
    SE1 7GN London
    Apt 711 East Block
    England
    Socio di LLP
    Forum Magnum Square
    SE1 7GN London
    Apt 711 East Block
    England
    Spain141654980003
    GWATIDZO, Nyasha
    Duck Lane
    Ludgershall
    HP18 9XZ Aylesbury
    Yew Tree Farm
    Buckinghamshier
    Socio di LLP
    Duck Lane
    Ludgershall
    HP18 9XZ Aylesbury
    Yew Tree Farm
    Buckinghamshier
    United Kingdom141416690001
    HALL, Nicholas John
    8 Prestwick Close
    Upton
    WA8 4DY Widnes
    Cheshire
    Socio di LLP
    8 Prestwick Close
    Upton
    WA8 4DY Widnes
    Cheshire
    United Kingdom77510870002
    HARRIS, Nicola Jane
    Beverley Penn Road
    Gospell End Village Sedgley
    DY3 4AG Dudley
    Socio di LLP
    Beverley Penn Road
    Gospell End Village Sedgley
    DY3 4AG Dudley
    United Kingdom67424430003
    HARRISON, Christopher Alan
    29 Stoatley Rise
    GU27 1AG Haslemere
    Socio di LLP
    29 Stoatley Rise
    GU27 1AG Haslemere
    United Kingdom7543220001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    24 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.26, LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over deposit and deed of assignment
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 29 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit by way of security the lease agreement the guarantee any and all substitute bank guarantees letters of credit or deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over deposit and deed of assignment
    Creato il 16 giu 2005
    Consegnato il 28 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit by way of security the lease agreement the guarantee any and all substitute bank guarantees letters of credit or deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over deposit and deed of assignment
    Creato il 02 giu 2005
    Consegnato il 06 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to the benefit of the lease agreement the guarantee the right to receive the guaranteed sums. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over deposit and deed of assignment
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the deposit and the debts represented by the deposit by way of security the lease agreement the guarantee any and all substitute bank guarantees letters of credit or deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Security agreement assignment and mortgage of copyright
    Creato il 09 mar 2005
    Consegnato il 22 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The collateral being the theatrical motion picture entitled mirrormask and all rights in and relating to the picture, the screenplay in respect of the picture, all rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sphe/U.K. Mirrormask Productions Llc
    Transazioni
    • 22 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment and charge
    Creato il 09 mar 2005
    Consegnato il 22 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all right, title and interest in and to the delivery material and the rights in relation to the film entitled mirrormask. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sphe/U.K. Mirrormask Productions Llc
    Transazioni
    • 22 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Copyright mortgage and assignment
    Creato il 09 mar 2005
    Consegnato il 22 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to the collateral relating to the motion picture currently entitled mirrormask. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sphe/U.K. Mirrormask Productions Llc
    Transazioni
    • 22 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0