EXCHANGE STATION LLP

EXCHANGE STATION LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXCHANGE STATION LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC315608
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova EXCHANGE STATION LLP?

    Indirizzo della sede legale
    Exchange Station
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXCHANGE STATION LLP?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BERMANS LLP09 mar 201209 mar 2012
    BERMANS (2011) LLP05 ott 201105 ott 2011
    BERMANS LLP11 ott 200511 ott 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXCHANGE STATION LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per EXCHANGE STATION LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bermans LLP\certificate issued on 25/01/23
    3 pagineCERTNM

    Avviso di cambio di nome"

    pagineLLNM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineLLCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineLLCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineLLCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Ann Nicola Benson come socio in data 12 ott 2019

    1 pagineLLTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineLLCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineLLCS01

    Modifiche ai dati del socio per Ann Nicola Benson in data 16 ago 2018

    2 pagineLLCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineLLCS01

    Cessazione della carica di Kieran Paul Donovan come socio in data 18 apr 2017

    1 pagineLLTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2016 con aggiornamenti

    4 pagineLLCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    5 pagineAA

    Soddisfazione della carica OC3156080006 per intero

    1 pagineLLMR04

    Cessazione della carica di Julie Celia Hunter come socio in data 31 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 ott 2015

    12 pagineLLAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EXCHANGE STATION LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAPMAN, Alexander
    20 Fairview Road
    Prenton
    CH43 5SD Birkenhead
    Socio designato di LLP
    20 Fairview Road
    Prenton
    CH43 5SD Birkenhead
    United Kingdom57327020001
    FARRELLY, Philip Anthony
    47 Mersey Road
    SK4 3DT Stockport
    Socio designato di LLP
    47 Mersey Road
    SK4 3DT Stockport
    United Kingdom142175140001
    GLEDHILL, David Brian
    11 Lowerfold Drive
    OL12 7JA Rochdale
    Socio designato di LLP
    11 Lowerfold Drive
    OL12 7JA Rochdale
    United Kingdom141897240001
    HARVEY, Nicholas
    Grange House Grange Walk
    CH48 8BT West Kirby
    Socio designato di LLP
    Grange House Grange Walk
    CH48 8BT West Kirby
    United Kingdom141897280001
    O'CLEIRIGH, Fergal Ronan
    Lyndhurst
    Neston Road
    CH64 4AP Ness
    Socio designato di LLP
    Lyndhurst
    Neston Road
    CH64 4AP Ness
    United Kingdom65424430002
    BERKSON, Jonathan
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    England
    Socio di LLP
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    England
    England178732160001
    DAVAGE, Jonathan
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    Socio di LLP
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    England157745190001
    FRYER, Adrian Neil
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    England
    Socio di LLP
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    England
    United Kingdom152503290001
    BARRETT, Bernard
    Brunagh 7 Stanley Road
    CH47 1HL Hoylake
    Socio designato di LLP
    Brunagh 7 Stanley Road
    CH47 1HL Hoylake
    12951500001
    HALL, John Wedgwood
    Mount Vyner
    Vyner Road South Noctorum
    CH43 7PW Birkenhead
    Socio designato di LLP
    Mount Vyner
    Vyner Road South Noctorum
    CH43 7PW Birkenhead
    United Kingdom12951510001
    MUNFORD, Ian Robertson
    Brackenhoe, 20 Clarendon Crescent
    M33 2DE Sale
    Socio designato di LLP
    Brackenhoe, 20 Clarendon Crescent
    M33 2DE Sale
    United Kingdom141897320001
    SINNETT, Peter Anthony
    54 Knowsley Road
    L19 0PG Liverpool
    Socio designato di LLP
    54 Knowsley Road
    L19 0PG Liverpool
    England141897300001
    CRS LEGAL SERVICES LIMITED
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    Socio designato di LLP
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    141188890001
    MC FORMATIONS LIMITED
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    Socio designato di LLP
    4 Clos Gwastir
    Castle View
    CF83 1TD Caerphilly
    141188900001
    BENSON, Ann Nicola
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    Socio di LLP
    Tithebarn Street
    L2 2QP Liverpool
    Exchange Station
    Merseyside
    United Kingdom87400690002
    DONOVAN, Kieran Paul
    The Copse
    L18 3NH Liverpool
    25
    Merseyside
    England
    Socio di LLP
    The Copse
    L18 3NH Liverpool
    25
    Merseyside
    England
    England157128150001
    HUNTER, Julie Celia
    Barrett Avenue
    Birkdale
    PR8 4PQ Southport
    2
    Merseyside
    Socio di LLP
    Barrett Avenue
    Birkdale
    PR8 4PQ Southport
    2
    Merseyside
    United Kingdom142467550001
    MCDERMOTT, Charles
    South Drive
    Sandfield Park
    L12 2AE Liverpool
    Ash Leigh
    Socio di LLP
    South Drive
    Sandfield Park
    L12 2AE Liverpool
    Ash Leigh
    United Kingdom20607170001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per EXCHANGE STATION LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    11 ott 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    EXCHANGE STATION LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 ago 2013
    Consegnato il 08 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (LLMR01)
    • 15 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Legal charge
    Creato il 10 mag 2010
    Consegnato il 22 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 4 43 st georges road westminster road london t/no NGL645102 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (LLMG01)
    • 13 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2007
    Consegnato il 29 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 4 43 st georges drive westminster london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Debenture
    Creato il 22 ago 2007
    Consegnato il 24 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 26 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Debenture
    Creato il 11 ago 2006
    Consegnato il 25 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0