PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP
Panoramica
Nome della società | PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società in accomandita semplice |
Numero di società | OC319739 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Dove si trova PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?
Indirizzo della sede legale | 2nd Floor, 48 Beak Street W1F 9RL London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 05 apr 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro | 3 pagine | LLDS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | LLCS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 1/1a Bakery Court London End Beaconsfield Buckinghamshire HP9 2FN a 2nd Floor, 48 Beak Street London W1F 9RL in data 09 mag 2017 | 1 pagine | LLAD01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 05 apr 2016 | 12 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 30 apr 2016 | 3 pagine | LLAR01 | ||
Modifiche ai dati del socio per Prescience Film Finance Limited in data 16 mag 2016 | 1 pagine | LLCH02 | ||
Cessazione della carica di Glyn Selwyn Williams come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Alistair Robert Winrow-Campbell come socio in data 21 feb 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Nigel David Walder come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Philip Stevens come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Martin James Westall come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Anthony George Fieming Philip come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Dominic Kevin O'carroll come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Brendan O Rourke come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Nicola Jane Merson come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Stuart Ian Kirk come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Kulvinder Singh Lall come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di David Mark Kirk come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Kenneth Alan Macpherson come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Matthew Robert Vincent Dickinson come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Eric William Jones come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Jason James Drewett come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Cessazione della carica di Tudor Michael Costigan come socio in data 21 dic 2015 | 1 pagine | LLTM01 | ||
Chi sono gli amministratori di PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESCIENCE FILM FINANCE LIMITED | Socio designato di LLP | London End HP9 2FN Beaconsfield 1/1a Bakery Court Buckinghamshire England |
| 142484570001 | ||||||||||
SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Socio designato di LLP | Moorgate EC2R 6AY London 25 United Kingdom |
| 141341430001 | ||||||||||
ARNOLD, Robert John Dart | Socio di LLP | The Old Forge Shere Road, Ewhurst GU6 7PJ Cranleigh | England | 142214600001 | ||||||||||
BROWN, Graham Maxwell | Socio di LLP | Field Corner Buckland Village HP22 5HY Aylesbury | England | 141279640001 | ||||||||||
COOK, Wayne Anthony | Socio di LLP | Forge Cottage 35 South Street Draycott DE72 3PP Derby | England | 141279770001 | ||||||||||
COSTIGAN, Tudor Michael | Socio di LLP | Sandal Road KT3 5AP New Malden 26 Surrey England | England | 142214610001 | ||||||||||
DICKINSON, Matthew Robert Vincent | Socio di LLP | 73 Downton Road SP2 8AT Salisbury | United Kingdom | 142214620001 | ||||||||||
DREWETT, Jason James, Dr | Socio di LLP | Dunadry House Broom Way KT13 9TG Weybridge | United Kingdom | 142214630001 | ||||||||||
JONES, Eric William | Socio di LLP | 14-18 Heddon Street Prescience W1B 4DA London Debello House England | England | 141869900002 | ||||||||||
KIRK, David Mark | Socio di LLP | Longacre Paddock Hill, Mobberley WA16 7DH Knutsford | United Kingdom | 93313960002 | ||||||||||
KIRK, Stuart Ian | Socio di LLP | Topps Cottage, Congleton Road Nether Alderley SK10 4TP Macclesfield | United Kingdom | 93313950001 | ||||||||||
LALL, Kulvinder Singh, Dr | Socio di LLP | 77 Hainault Road IG7 5DL Chigwell | England | 46745000001 | ||||||||||
MACPHERSON, Kenneth Alan | Socio di LLP | 10 Milburn Walk KT18 3JN Epsom Surrey | United Kingdom | 142214710001 | ||||||||||
MERSON, Nicola Jane | Socio di LLP | Wyfold Lodge Cottage Wyfold RG4 9HU Reading | United Kingdom | 142214660001 | ||||||||||
O ROURKE, Brendan | Socio di LLP | 31 Frankfurt Road Herne Hill SE24 9NX London | United Kingdom | 141462050001 | ||||||||||
O'CARROLL, Dominic Kevin, Mr. | Socio di LLP | The Pines 4 Chaworth Close KT16 0LS Ottershaw | United Kingdom | 141455790001 | ||||||||||
PHILIP, Anthony George Fieming | Socio di LLP | New Barn Farm Sibford Gower OX15 5RY Banbury | United Kingdom | 142214680001 | ||||||||||
STEVENS, Andrew Philip | Socio di LLP | Bridge Cottage Henley TA10 9BH Langport | England | 142214690001 | ||||||||||
WALDER, Nigel David | Socio di LLP | 19 Courthope Road Wimbledon Village SW19 7RD London | England | 73052250001 | ||||||||||
WESTALL, Martin James | Socio di LLP | Charlton All Saints SP5 4HD Salisbury Charlton Manor Farm | England | 152755570001 | ||||||||||
WILLIAMS, Glyn Selwyn | Socio di LLP | Cock Lane HP13 6XJ High Wycombe 69a Buckinghamshire | England | 141906630004 | ||||||||||
WINROW-CAMPBELL, Alistair Robert | Socio di LLP | Maldon House Blockley GL56 Moreton-In-Marsh | United Kingdom | 142214700001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
30 apr 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge and deed of assignment | Creato il 07 set 2007 Consegnato il 25 set 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed charge all right title and interest in and to the film all pre print elements all positive prints all soundtrack elements any and all documents all machinery all present and future deposit and other accounts all cash all physical properties of every kind relating to the film the proceeds of anyand/or all of the foregoing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 03 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1000,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Charge over the property assets and interest in respect of a film provisionally entitled the edge of love. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 20 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the collateral all pre-print elements all prints soundtrack elements any and all documents receipts or books in respect to the film entitled "the egde of love". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge and deed of assignment | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 29 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us$8,353,132 and all other sums from time to time from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the film entitled "the best time of our lives" and all collateral allied ancillary and subsidiary rights and all properties and things of value. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge and deed of assignment | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 25 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All pre-print elements capable of producing prints or additional pre-print elements including without limitation master negatives... All positive prints negatives prints exposed film developed film... In relation to the film. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 giu 2007 Consegnato il 20 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over a dedicated security account | Creato il 05 set 2006 Consegnato il 07 set 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns the benefit of the monies now held from time to time in the dedicated security account. By way of fixed and floating charge the right title and interest in and to the dedicated security account and all sums standing to the credit in the dedicated security account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0