PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP

PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC319739
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor, 48 Beak Street
    W1F 9RL London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    3 pagineLLDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2017 con aggiornamenti

    4 pagineLLCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1/1a Bakery Court London End Beaconsfield Buckinghamshire HP9 2FN a 2nd Floor, 48 Beak Street London W1F 9RL in data 09 mag 2017

    1 pagineLLAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 05 apr 2016

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2016

    3 pagineLLAR01

    Modifiche ai dati del socio per Prescience Film Finance Limited in data 16 mag 2016

    1 pagineLLCH02

    Cessazione della carica di Glyn Selwyn Williams come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Alistair Robert Winrow-Campbell come socio in data 21 feb 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Nigel David Walder come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Andrew Philip Stevens come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Martin James Westall come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Anthony George Fieming Philip come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Dominic Kevin O'carroll come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Brendan O Rourke come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Nicola Jane Merson come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Stuart Ian Kirk come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Kulvinder Singh Lall come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di David Mark Kirk come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Kenneth Alan Macpherson come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Matthew Robert Vincent Dickinson come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Eric William Jones come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Jason James Drewett come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Tudor Michael Costigan come socio in data 21 dic 2015

    1 pagineLLTM01

    Chi sono gli amministratori di PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRESCIENCE FILM FINANCE LIMITED
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Socio designato di LLP
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04885246
    142484570001
    SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    United Kingdom
    Socio designato di LLP
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00976145
    141341430001
    ARNOLD, Robert John Dart
    The Old Forge
    Shere Road, Ewhurst
    GU6 7PJ Cranleigh
    Socio di LLP
    The Old Forge
    Shere Road, Ewhurst
    GU6 7PJ Cranleigh
    England142214600001
    BROWN, Graham Maxwell
    Field Corner
    Buckland Village
    HP22 5HY Aylesbury
    Socio di LLP
    Field Corner
    Buckland Village
    HP22 5HY Aylesbury
    England141279640001
    COOK, Wayne Anthony
    Forge Cottage 35 South Street
    Draycott
    DE72 3PP Derby
    Socio di LLP
    Forge Cottage 35 South Street
    Draycott
    DE72 3PP Derby
    England141279770001
    COSTIGAN, Tudor Michael
    Sandal Road
    KT3 5AP New Malden
    26
    Surrey
    England
    Socio di LLP
    Sandal Road
    KT3 5AP New Malden
    26
    Surrey
    England
    England142214610001
    DICKINSON, Matthew Robert Vincent
    73 Downton Road
    SP2 8AT Salisbury
    Socio di LLP
    73 Downton Road
    SP2 8AT Salisbury
    United Kingdom142214620001
    DREWETT, Jason James, Dr
    Dunadry House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    Socio di LLP
    Dunadry House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    United Kingdom142214630001
    JONES, Eric William
    14-18 Heddon Street
    Prescience
    W1B 4DA London
    Debello House
    England
    Socio di LLP
    14-18 Heddon Street
    Prescience
    W1B 4DA London
    Debello House
    England
    England141869900002
    KIRK, David Mark
    Longacre
    Paddock Hill, Mobberley
    WA16 7DH Knutsford
    Socio di LLP
    Longacre
    Paddock Hill, Mobberley
    WA16 7DH Knutsford
    United Kingdom93313960002
    KIRK, Stuart Ian
    Topps Cottage, Congleton Road
    Nether Alderley
    SK10 4TP Macclesfield
    Socio di LLP
    Topps Cottage, Congleton Road
    Nether Alderley
    SK10 4TP Macclesfield
    United Kingdom93313950001
    LALL, Kulvinder Singh, Dr
    77 Hainault Road
    IG7 5DL Chigwell
    Socio di LLP
    77 Hainault Road
    IG7 5DL Chigwell
    England46745000001
    MACPHERSON, Kenneth Alan
    10 Milburn Walk
    KT18 3JN Epsom
    Surrey
    Socio di LLP
    10 Milburn Walk
    KT18 3JN Epsom
    Surrey
    United Kingdom142214710001
    MERSON, Nicola Jane
    Wyfold Lodge Cottage
    Wyfold
    RG4 9HU Reading
    Socio di LLP
    Wyfold Lodge Cottage
    Wyfold
    RG4 9HU Reading
    United Kingdom142214660001
    O ROURKE, Brendan
    31 Frankfurt Road
    Herne Hill
    SE24 9NX London
    Socio di LLP
    31 Frankfurt Road
    Herne Hill
    SE24 9NX London
    United Kingdom141462050001
    O'CARROLL, Dominic Kevin, Mr.
    The Pines
    4 Chaworth Close
    KT16 0LS Ottershaw
    Socio di LLP
    The Pines
    4 Chaworth Close
    KT16 0LS Ottershaw
    United Kingdom141455790001
    PHILIP, Anthony George Fieming
    New Barn Farm
    Sibford Gower
    OX15 5RY Banbury
    Socio di LLP
    New Barn Farm
    Sibford Gower
    OX15 5RY Banbury
    United Kingdom142214680001
    STEVENS, Andrew Philip
    Bridge Cottage
    Henley
    TA10 9BH Langport
    Socio di LLP
    Bridge Cottage
    Henley
    TA10 9BH Langport
    England142214690001
    WALDER, Nigel David
    19 Courthope Road
    Wimbledon Village
    SW19 7RD London
    Socio di LLP
    19 Courthope Road
    Wimbledon Village
    SW19 7RD London
    England73052250001
    WESTALL, Martin James
    Charlton All Saints
    SP5 4HD Salisbury
    Charlton Manor Farm
    Socio di LLP
    Charlton All Saints
    SP5 4HD Salisbury
    Charlton Manor Farm
    England152755570001
    WILLIAMS, Glyn Selwyn
    Cock Lane
    HP13 6XJ High Wycombe
    69a
    Buckinghamshire
    Socio di LLP
    Cock Lane
    HP13 6XJ High Wycombe
    69a
    Buckinghamshire
    England141906630004
    WINROW-CAMPBELL, Alistair Robert
    Maldon House
    Blockley
    GL56 Moreton-In-Marsh
    Socio di LLP
    Maldon House
    Blockley
    GL56 Moreton-In-Marsh
    United Kingdom142214700001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    30 apr 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge and deed of assignment
    Creato il 07 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest in and to the film all pre print elements all positive prints all soundtrack elements any and all documents all machinery all present and future deposit and other accounts all cash all physical properties of every kind relating to the film the proceeds of anyand/or all of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cinefinance Insurance Services, Llc
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Legal charge
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 03 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1000,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Charge over the property assets and interest in respect of a film provisionally entitled the edge of love.
    Persone aventi diritto
    • British Broadcasting Corporation
    Transazioni
    • 03 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 20 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the collateral all pre-print elements all prints soundtrack elements any and all documents receipts or books in respect to the film entitled "the egde of love". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge and deed of assignment
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 29 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us$8,353,132 and all other sums from time to time from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the film entitled "the best time of our lives" and all collateral allied ancillary and subsidiary rights and all properties and things of value. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 29 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge and deed of assignment
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 25 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All pre-print elements capable of producing prints or additional pre-print elements including without limitation master negatives... All positive prints negatives prints exposed film developed film... In relation to the film.
    Persone aventi diritto
    • Finance Wales Investments (4) Limited
    Transazioni
    • 25 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Debenture
    Creato il 08 giu 2007
    Consegnato il 20 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over a dedicated security account
    Creato il 05 set 2006
    Consegnato il 07 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns the benefit of the monies now held from time to time in the dedicated security account. By way of fixed and floating charge the right title and interest in and to the dedicated security account and all sums standing to the credit in the dedicated security account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0