CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP

CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC351693
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP?

    Indirizzo della sede legale
    56 Berry Drive
    Berry Drive
    TQ3 3QW Paignton
    Devon
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    8 pagineLLDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 gen 2017 con aggiornamenti

    4 pagineLLCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2016

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2016

    40 pagineLLAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2015

    40 pagineLLAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2014

    40 pagineLLAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2013

    4 pagineAA

    Modifiche ai dati del socio per The Project Management Company in data 31 lug 2013

    1 pagineLLCH02

    Modifiche ai dati del socio per Mr & Mrs David Trevor Barker in data 17 lug 2013

    2 pagineLLCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 4 Belmont Road Stroud Gloucestershire GL5 1HH England* in data 17 lug 2013

    1 pagineLLAD01

    Modifiche ai dati del socio per Ms Teresa Rose Rolland in data 18 giu 2013

    2 pagineLLCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor Honours Building Akeman Business Park, Akeman St Tring Herts HP23 6AF United Kingdom* in data 07 giu 2013

    1 pagineLLAD01

    Modifiche ai dati del socio per Mr Paul Hamo Thornycroft in data 09 mag 2013

    2 pagineLLCH01

    Cessazione della carica di Cavendish Moore Limited come socio

    1 pagineLLTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 gen 2013

    41 pagineLLAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2012

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Leach come socio

    1 pagineLLTM01

    Bilancio annuale redatto al 22 gen 2012

    42 pagineLLAR01

    Modifiche ai dati del socio per Cavendish Moore Limited in data 23 nov 2011

    1 pagineLLCH02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Mrs Lesley Ann Adams come socio

    2 pagineLLAP01

    Chi sono gli amministratori di CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARKER, David Trevor
    Berry Drive
    TQ3 3QW Paignton
    56
    Devon
    Socio designato di LLP
    Berry Drive
    TQ3 3QW Paignton
    56
    Devon
    England72398200001
    ROLLAND, Teresa Rose
    Le Vier Mont
    JE2 4NG St Helier
    2 Melrose Cottage
    Jersey
    Channel Islands
    Socio designato di LLP
    Le Vier Mont
    JE2 4NG St Helier
    2 Melrose Cottage
    Jersey
    Channel Islands
    Channel Islands160992700001
    THORNYCROFT, Paul Hamo
    Belmont Road
    GL5 1HH Stroud
    4
    Gloucestershire
    Socio designato di LLP
    Belmont Road
    GL5 1HH Stroud
    4
    Gloucestershire
    United Kingdom150070070001
    ADAMS, Lesley Ann
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PD London
    26
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PD London
    26
    United Kingdom
    United Kingdom149726140001
    AINGER, Colin Peter
    The Old Orchard
    Mill Lane Calcot
    RG31 7RF Reading
    Pear Tree Cottage
    Berkshire
    Socio di LLP
    The Old Orchard
    Mill Lane Calcot
    RG31 7RF Reading
    Pear Tree Cottage
    Berkshire
    England149726040001
    BATTAGEL, Joanna Margaret, Dr
    Elm Close
    Farnham Common
    SL2 3NA Slough
    Elm Cottage
    Berks
    Socio di LLP
    Elm Close
    Farnham Common
    SL2 3NA Slough
    Elm Cottage
    Berks
    United Kingdom151226560001
    BOTTOMLEY, Raymond
    Woodville Terrace
    Douglas
    IM2 4HA Isle Of Man
    3
    Socio di LLP
    Woodville Terrace
    Douglas
    IM2 4HA Isle Of Man
    3
    United Kingdom109205080001
    BROWN, Cedric Clive, Professor
    Brewery Common
    Mortimer
    RG7 3RH Reading
    Knotmead Lodge
    Berks
    Socio di LLP
    Brewery Common
    Mortimer
    RG7 3RH Reading
    Knotmead Lodge
    Berks
    Uk151224710001
    CHALVET, John
    Wharfedale Gardens
    CR7 6LD Thornton Heath
    43
    Surrey
    Socio di LLP
    Wharfedale Gardens
    CR7 6LD Thornton Heath
    43
    Surrey
    Uk152983850001
    COTTERILL, Seton
    Great Oak
    Raglan
    NP15 2AQ Usk
    Cae Capel
    Gwent
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Great Oak
    Raglan
    NP15 2AQ Usk
    Cae Capel
    Gwent
    United Kingdom
    United Kingdom160194860001
    DANES, Peter
    Mountbatten Road
    LE15 6LS Oakham
    3
    Leicestershire
    Socio di LLP
    Mountbatten Road
    LE15 6LS Oakham
    3
    Leicestershire
    United Kingdom151225060001
    DAVEY, Robert
    Whitfield Way
    NN2 8LG Northampton
    5
    Northamptonshire
    Socio di LLP
    Whitfield Way
    NN2 8LG Northampton
    5
    Northamptonshire
    England153638290002
    DODGSON, Arthur
    Eden Way
    TS22 5NU Billingham
    14
    Cleveland
    Socio di LLP
    Eden Way
    TS22 5NU Billingham
    14
    Cleveland
    United Kingdom28016810001
    DOWN, Michael Geoffrey
    Upper Belgrave Road
    BS8 2XJ Bristol
    10 Clifton Down Mansions 12
    Socio di LLP
    Upper Belgrave Road
    BS8 2XJ Bristol
    10 Clifton Down Mansions 12
    England150069370001
    EDWARDS, Bengt Lennart Ulfsson
    Kantorsvagen 74
    Svedala
    S-23339
    Sweden
    Socio di LLP
    Kantorsvagen 74
    Svedala
    S-23339
    Sweden
    Sweden151598630002
    FRASER, Simon Legassicke Stewart
    Elm Grove
    PO22 0HJ Barnham
    65
    West Sussex
    Socio di LLP
    Elm Grove
    PO22 0HJ Barnham
    65
    West Sussex
    United Kingdom151225600002
    GORDON, James Stuart, Lord
    Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    Deils Craig
    Socio di LLP
    Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    Deils Craig
    Uk86771460001
    GOUGH, Graham William
    Rushbury
    SY6 7DY Church Stretton
    2 Nursery Fields
    Shropshire
    Socio di LLP
    Rushbury
    SY6 7DY Church Stretton
    2 Nursery Fields
    Shropshire
    United Kingdom121508510001
    GULZAR, Mahmood Ahmed
    Burwash Road
    RH10 6LG Crawley
    46
    West Sussex
    Socio di LLP
    Burwash Road
    RH10 6LG Crawley
    46
    West Sussex
    Uk151855690001
    HOLFORD, Graham Roland
    Veals Lane
    Marchwood
    SO40 4WW Southampton
    Testside
    Hampshire
    Socio di LLP
    Veals Lane
    Marchwood
    SO40 4WW Southampton
    Testside
    Hampshire
    Uk153638520001
    LOVE, Terence Cyril
    Millfield Castleton Way
    IP23 7DE Eye
    8
    Suffolk
    Socio di LLP
    Millfield Castleton Way
    IP23 7DE Eye
    8
    Suffolk
    England150065300001
    LUTLEY, Albert Davis
    Nicholas Road
    Tower Hamlets
    E1 4HT London
    11 Colin Winter House
    Socio di LLP
    Nicholas Road
    Tower Hamlets
    E1 4HT London
    11 Colin Winter House
    Uk151223380001
    MCGRATH, Kevin Anthony
    Loughview Road
    BT29 4RE Crumlin
    50a
    Antrim
    Socio di LLP
    Loughview Road
    BT29 4RE Crumlin
    50a
    Antrim
    Uk153638200001
    MCMAHON, Patrick, Father
    1 St Clements Road
    ME21 9EE Chorlton
    St Johns
    Manchester
    Socio di LLP
    1 St Clements Road
    ME21 9EE Chorlton
    St Johns
    Manchester
    England151857610001
    MILNER, Hartley John Charles
    Hunters Close
    HP23 5QA Tring
    52
    Herts
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Hunters Close
    HP23 5QA Tring
    52
    Herts
    United Kingdom
    United Kingdom151586450002
    MORRIS, Alan Geoffrey
    Chalcombe Road
    Kingsthorpe
    NN2 8JD Northampton
    33
    Northamptonshire
    Socio di LLP
    Chalcombe Road
    Kingsthorpe
    NN2 8JD Northampton
    33
    Northamptonshire
    United Kingdom149753960001
    PARKER, David Michael
    West Parade
    BN11 3PL Worthing
    Flat 14 Balcombe Court
    West Sussex
    Socio di LLP
    West Parade
    BN11 3PL Worthing
    Flat 14 Balcombe Court
    West Sussex
    United Kingdom147489880001
    PATEL, Alka
    Glen Way
    Oadby
    LE2 5YF Leicester
    15
    Leicestershire
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Glen Way
    Oadby
    LE2 5YF Leicester
    15
    Leicestershire
    United Kingdom
    United Kingdom151857900003
    PATEL, Mukesh
    Spion Kop
    Glen Rise Oadby
    LE2 4QN Leicester
    1
    Socio di LLP
    Spion Kop
    Glen Rise Oadby
    LE2 4QN Leicester
    1
    United Kingdom120470960001
    SELLEK, Peter Francis
    Filton Avenue
    Filton
    BS34 7AR Bristol
    907
    Socio di LLP
    Filton Avenue
    Filton
    BS34 7AR Bristol
    907
    United Kingdom149752790001
    SIMPSON, Robert Peter
    Tudor Way
    Church Crookham
    GU52 6LX Fleet
    50
    Hampshire
    Socio di LLP
    Tudor Way
    Church Crookham
    GU52 6LX Fleet
    50
    Hampshire
    England4009150001
    TATE, Herbert Michael
    91 St Marys Road
    PO11 9DD Hayling Island
    Rook Farm House
    Hants
    Socio di LLP
    91 St Marys Road
    PO11 9DD Hayling Island
    Rook Farm House
    Hants
    United Kingdom102717950001
    THOROGOOD, Richard George
    New Hall Lane
    Mundon
    CM9 6PJ Maldon
    White House Manor
    Essex
    Socio di LLP
    New Hall Lane
    Mundon
    CM9 6PJ Maldon
    White House Manor
    Essex
    England151013490001
    TURNER, Neil Raymond
    144-146 Langett Road South
    Oughtbridge
    S35 0HA Sheffield
    Birch House
    South Yorkshire
    Socio di LLP
    144-146 Langett Road South
    Oughtbridge
    S35 0HA Sheffield
    Birch House
    South Yorkshire
    United Kingdom151586660001
    TYLER, Roger Medhurst
    Old Brampton
    S42 7JF Chesterfield
    Woodnook Cottage
    Derbyshire
    Socio di LLP
    Old Brampton
    S42 7JF Chesterfield
    Woodnook Cottage
    Derbyshire
    United Kingdom151225350001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CAVENDISH MOORE PROPERTY PARTNERSHIP (NEWCASTLE UNDER LYME STAFFORDSHIRE) LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    18 gen 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0