THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED

THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC001846
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY PLC02 apr 188902 apr 1889

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato)

    10 pagineLIQ13(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX in data 20 lug 2018

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Zahra Peermohamed come segretario in data 19 lug 2018

    1 pagineTM02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    2 pagineAD02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 giu 2018

    LRESSP

    Nomina di Miss Zahra Peermohamed come segretario in data 01 mar 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stephen Roy Slocombe come segretario in data 28 feb 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stephen Roy Slocombe come amministratore in data 28 feb 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Stewart Girling come amministratore in data 11 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Damien Ivo Karlov come amministratore in data 28 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Manager Derek Carter come amministratore in data 24 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anupam Manchanda come amministratore in data 02 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 405 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 404 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 399 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 369 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 395 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 320 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 347 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Amministratore
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    United KingdomBritish225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    Segretario
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    British117898690001
    BEWSEY, Martin Roy
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    Segretario
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    British88472130001
    BROWN, David Allan
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    Segretario
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    British37710002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Segretario
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    PARSONS-WEISS, Beatrix
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Segretario
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    German93618170002
    PEERMOHAMED, Zahra
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Segretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    243694040001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Segretario
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    British55097590003
    THOMSON, Alan Herbert
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    Segretario
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    British293000001
    ABRAMSON, Christoffer
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Amministratore
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Swedish98463110004
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Amministratore
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BIRCH, Paul Adrian
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Amministratore
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    ScotlandBritish772720001
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Amministratore
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183344960001
    BURTON, Caroline Mary
    3 Helmet Row
    EC1V 3QJ London
    Amministratore
    3 Helmet Row
    EC1V 3QJ London
    EnglandBritish596070001
    CAIRNS, James Scott
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    British33041530001
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Amministratore
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrish90824990003
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Amministratore
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritish59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Amministratore
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish107819460001
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JACK, Robert Barr, Professor
    50 Lanton Road
    Lanton Park
    G43 2SR Glasgow
    Amministratore
    50 Lanton Road
    Lanton Park
    G43 2SR Glasgow
    ScotlandBritish940950004
    KANE, William James
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    Amministratore
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    British73972820001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish202318870001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Amministratore
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    LEE, David Robert
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910001
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish96177720001
    MACPHERSON, John Hannah Forbes
    16 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Amministratore
    16 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    British295710001
    MALCOLM, David
    40 Priory Drive
    RH2 8AF Reigate
    Surrey
    Amministratore
    40 Priory Drive
    RH2 8AF Reigate
    Surrey
    British295690001
    MANCHANDA, Anupam
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomIndian196338510001
    MARFLEET, Thomas
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish139855250001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    14 dic 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Cash deposit pledge
    Creato il 26 mag 2004
    Consegnato il 03 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The company pledges and assigns the charged account and the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Cash deposit pledge
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 06 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The company pledges and assigns the charged account and the deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Cash deposit pledge
    Creato il 03 feb 2004
    Consegnato il 16 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The charged account and deposit. Account no. 06019951 and the sum of £1,276,957.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Cash deposit pledge
    Creato il 20 gen 2004
    Consegnato il 30 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Company pledges and assigns the charged account and deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 dic 2003
    Consegnato il 13 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 1.358 ha situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 23 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brevi particolari
    The rental income in relation to 27 milton link, newcraighall, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The whole of the obligations as contained in the contract
    Brevi particolari
    12/12A south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Meadowfield Developments Limited
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The whole obligations as contained in the contract
    Brevi particolari
    20/22 south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Meadowfield Developments Limited
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The whole obligations as contained in the contract
    Brevi particolari
    23 south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Meadowfield Developments Limited
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Payment of stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of a trust deed
    Brevi particolari
    201/205 x 207 dalry road and 24 orwell terrace, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed
    Brevi particolari
    The subjects on the east side of mavor avenue and the north side of howard avenue, east kilbride--title number LAN36104.
    Persone aventi diritto
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as defined in the trust deed
    Brevi particolari
    32/46 houston street, glasgow--title number GLA33572.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed
    Brevi particolari
    19-25 houston street, glasgow--title number GLA102404 and 33 houston street, glasgow--title number GLA102402.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as in the trust deed
    Brevi particolari
    The subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 16 giu 2003
    Consegnato il 18 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piccadilly trading estate, manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The road on the north or northwest leading from cadzoe street to hamilton station, hamilton.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    223/229 ingram street and 91 miller street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    20/22 south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    23 south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    12/12A south gyle crescent, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piece of ground situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road link/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    201/205 dalry road, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 13 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Princes mall shopping centre, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 gen 2003
    Consegnato il 20 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    42/50 watt street, glasgow--title number GLA93893.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 set 2019Data prevista di scioglimento
    19 giu 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0