PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC003935 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 115 4th Floor 115 George Street EH2 4JN Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PENTLAND BRANDS LAKESIDE PLC | 12 gen 2016 | 12 gen 2016 |
| PENTLAND BRANDS PLC | 09 apr 2010 | 09 apr 2010 |
| PENTLAND BRANDS PLC | 09 dic 2002 | 09 dic 2002 |
| PENTLAND GROUP PLC | 31 lug 1989 | 31 lug 1989 |
| BERTRAMS INVESTMENT TRUST PLC | 16 mag 1986 | 16 mag 1986 |
| BERTRAMS PUBLIC LIMITED COMPANY | 30 giu 1898 | 30 giu 1898 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 gen 2027 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 ott 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2026 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 08 ago 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 22 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 08 ago 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2026 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2025 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2024 al 31 gen 2025 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 12 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modifica dei dettagli di Pentland Group (Trading) Limited come persona con controllo significativo il 16 gen 2023 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di Pentland Group (Trading) Limited come persona con controllo significativo il 02 nov 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Pentland Group Limited come persona con controllo significativo il 02 nov 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Chirag Yashvant Patel il 01 apr 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Katrina Lesley Nurse come amministratore in data 30 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Pentland Group Plc come persona con controllo significativo il 20 nov 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULLEN, Timothy Edward | Segretario | Manchester Square W1U 3PH London 8 England And Wales United Kingdom | 197221600001 | |||||||
| LONG, Andrew Michael | Amministratore | Manchester Square W1U 3PH London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 110153850002 | |||||
| PATEL, Chirag Yashvant | Amministratore | Manchester Square W1U 3PH London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 243023560002 | |||||
| RUBIN, Andrew Keith | Amministratore | Manchester Square W1U 3PH London 8 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 33080510003 | |||||
| CAMPBELL, Patrick James | Segretario | 4th Floor 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 115 Scotland | British | 17183850001 | ||||||
| GOPSILL, Michael Clement | Segretario | Wood Cottage Norton Road Iverley Stourbridge West Midlands | British | 32481900001 | ||||||
| STEVENS, Richard Anthony | Segretario | 5 Desborough Drive Tewin Wood AL6 0HQ Welwyn Hertfordshire | British | 804740002 | ||||||
| BERNSTEIN, David Alan | Amministratore | 48 Fitzalan Road Finchley N3 3PE London | United Kingdom | British | 87832960001 | |||||
| BROWN, Ean Bryan | Amministratore | 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN | England | British | 54609340003 | |||||
| CHARLTON, John Stuart Northcliffe | Amministratore | Englefield Lodge Middle Hill Englefield Green TW20 0JR Egham Surrey | United Kingdom | British | 12417140001 | |||||
| FARIS, Trevor Keith | Amministratore | Orchard Cottage Effingham Common Effingham KT24 5JE Leatherhead Surrey | British | 104120001 | ||||||
| FARRANT, Frank Arthur | Amministratore | Glenmore Uxbridge Road Hatch End HA5 4RB Pinner Middlesex | British | 14514880001 | ||||||
| FROY, Robert Anthony Douglas | Amministratore | Little Chart 46 Oakhill Road TN13 1NS Sevenoaks Kent | British | 35373020001 | ||||||
| GILBURD, Samantha Elizabeth | Amministratore | Manchester Square W1U 3PH London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 172614870001 | |||||
| GUTHRIE, John | Amministratore | . Little Hilla Green Farm, Troutsdale YO13 0BS Scarborough North Yorkshire | England | British | 946780001 | |||||
| KEYSER, Anthony John De | Amministratore | 2 Constable Close NW11 6TY London | British | 804720001 | ||||||
| LESLIE, Andrew Marvin | Amministratore | 1 Broadlands Hillside Road WD7 7BX Radlett Hertfordshire | England | British | 80618290001 | |||||
| MATCHAN, Christopher John | Amministratore | Armitage House 11 Armitage Court SL5 9TA Sunninghill Berkshire | British | 72381930001 | ||||||
| MAYO, John Charles | Amministratore | 1 Ellerdale Close Hampstead NW3 6BE London | England | British | 79394990001 | |||||
| MCGUIGAN, Peter | Amministratore | Green Walk Bowdon WA14 2SN Altrincham Telfa House Cheshire United Kingdom | England | British | 136211350001 | |||||
| MOK-KIRKMAN, Anne | Amministratore | 5/F Blk F Pearl Gardens 7 Conduit Road Hong Kong Hk Hk | British | 75367970002 | ||||||
| NURSE, Katrina Lesley | Amministratore | Manchester Square W1U 3PH London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 186571490001 | |||||
| OPENSHAW, Nigel Edmond Kippax | Amministratore | Tulls Cottage RG25 2EM Preston Candover Hampshire | British | 21929340003 | ||||||
| PEARSON, David Charles | Amministratore | 9 The Warren AL5 2NH Harpenden Hertfordshire | Uk | Uk | 60337060001 | |||||
| QUELCH, John Anthony | Amministratore | 57 Baker Bridge Road Lincoln Massachusetts 01773 Usa | Usa | Usa | 86608900001 | |||||
| RUBIN OBE, Robert Stephen | Amministratore | NW3 | United Kingdom | British | 8518810004 | |||||
| SHEPHERD, Robert Priestley | Amministratore | Woodcliffe Horncliffe BB4 6JS Rossendale Lancashire | British | 8802110001 | ||||||
| SHEPHERD, Robert Priestley | Amministratore | Woodcliffe Horncliffe BB4 6JS Rossendale Lancashire | British | 8802110001 | ||||||
| SILVER, Clinton Vita | Amministratore | Rodgarden Shaw OX10 6QT Ipsden Oxfordshire | British | 43031960001 | ||||||
| SINCLAIR, Jonathan Stuart | Amministratore | The Pentland Centre Lakeside East Lakeside Squires Lane N3 2QL Finchley Central London | British | 45080280005 | ||||||
| STEVENS, Richard Anthony | Amministratore | 5 Desborough Drive Tewin Wood AL6 0HQ Welwyn Hertfordshire | British | 804740002 | ||||||
| TAYLOR, Russell Hay | Amministratore | 27 Penland Road RH16 1PP Haywards Heath West Sussex | British | 80670780001 | ||||||
| WEBB, Charles Maxwell | Amministratore | 31 Ponsonby Terrace SW1P 4PZ London | British | 28863200001 | ||||||
| WEBSTER, Nicholas Peter Hamilton | Amministratore | Yew Tree Cottage 40 Little Gaddesden HP4 1PQ Berkhamsted Hertfordshire | British | 501960001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PENTLAND BRANDS LAKESIDE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentland Group Limited | 02 nov 2021 | Manchester Square W1U 3PH London 8 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Pentland Group Limited | 06 apr 2016 | Manchester Square W1U 3PH London 8 England And Wales United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0