JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED

JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJOHN SMITH & SON GROUP LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC006905
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
    • Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione

    Dove si trova JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Building 1 9 Haymarket Square
    EH3 8RY Edinburgh
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOHN SMITH & SON (GLASGOW) LIMITED24 set 190824 set 1908

    Quali sono gli ultimi bilanci di JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al29 mag 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il28 feb 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 giu 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 ott 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 ott 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 ott 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Modifica dei dettagli di Js Group Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 06 ott 2025

    2 paginePSC05

    Notifica di Js Group Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 06 ott 2025

    2 paginePSC02

    Cessazione di Cubit Group Ltd come persona con controllo significativo il 06 ott 2025

    1 paginePSC07

    Risoluzioni

    Resolutions
    9 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Leigh Gray il 29 set 2025

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Richard Hugo Wyndham Mahoney come amministratore in data 01 lug 2025

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 02 giu 2024

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2024 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 mag 2023

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor North Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN United Kingdom a Building 1 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY in data 05 mag 2023

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Nicholas Siegfried Dale come amministratore in data 23 mar 2023

    2 pagineAP01

    Notifica di Cubit Group Ltd come persona con controllo significativo il 20 feb 2023

    2 paginePSC02

    Cessazione di Peter Leigh Gray come persona con controllo significativo il 20 feb 2023

    1 paginePSC07

    Bilancio redatto al 29 mag 2022

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 29 mag 2021

    40 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 29 mag 2020

    43 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca SC0069050011, creata il 27 ago 2020

    5 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOOKS, Matthew Guy
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    Segretario
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    199756060001
    DALE, Nicholas Siegfried
    West Quay Road
    SO15 1GZ Southampton
    John Smith & Son Group
    England
    Amministratore
    West Quay Road
    SO15 1GZ Southampton
    John Smith & Son Group
    England
    EnglandBritish240399690001
    GRAY, Peter Leigh
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish33825380001
    LAKE, Peter William
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish78374180001
    LINDSAY, Stuart Robert
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish86894330002
    MAHONEY, Richard Hugo Wyndham
    West Quay Road
    SO15 1GZ Southampton
    John Smith & Son Group
    England
    Amministratore
    West Quay Road
    SO15 1GZ Southampton
    John Smith & Son Group
    England
    EnglandBritish294816770001
    MARSHALL, David Craig
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o John Smith & Son Group Ltd
    Units 3 & 4
    West Quay Trade Park
    SO15 1GZ Southampton
    Engagement House
    Hampshire
    England
    ScotlandBritish209390570001
    ADAMS, Edward Laurence John
    60 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Capella Building (Tenth Floor)
    Segretario
    60 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Capella Building (Tenth Floor)
    196254390001
    JEYES, Peter Martin
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    British5253210001
    NOTARANGELO, Pietro Raffaele
    25 Dalkeith Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2HQ Glasgow
    Segretario
    25 Dalkeith Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2HQ Glasgow
    British32052400002
    SHEARER, Robert Coutts
    Glynhurst 45 Polmont Road
    Laurieston
    FK2 9QS Falkirk
    Stirlingshire
    Segretario
    Glynhurst 45 Polmont Road
    Laurieston
    FK2 9QS Falkirk
    Stirlingshire
    British927710001
    TURNER, David J
    10 Central Avenue
    Mount Vernon
    G32 9JP Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    10 Central Avenue
    Mount Vernon
    G32 9JP Glasgow
    Lanarkshire
    British256030001
    ANDERSON, William Taylor Campbell
    Crossburn
    Milngavie
    G62 7HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Crossburn
    Milngavie
    G62 7HJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish64578480001
    ANDERSON, William Taylor Campbell
    Crossburn
    Milngavie
    G62 7HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Crossburn
    Milngavie
    G62 7HJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish64578480001
    BURSEY, Sam
    Headlands Business Park
    Salisbury Road
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Headlands Business Park
    Salisbury Road
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish296056540001
    CLOW, Robert George Menzies
    Aiket Castle
    KA3 4BW Dunlop
    Ayrshire
    Amministratore
    Aiket Castle
    KA3 4BW Dunlop
    Ayrshire
    United KingdomBritish256040001
    DOUGLAS, Joan
    7 Lower Bourtree Drive
    Rutherglen
    G73 4RG Glasgow
    Amministratore
    7 Lower Bourtree Drive
    Rutherglen
    G73 4RG Glasgow
    British61251460001
    FIELD, Terence Frederick
    The Penthouse
    Flat 7 Chine Lodge, 80 Westcliffe Road
    BH4 8BG Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    The Penthouse
    Flat 7 Chine Lodge, 80 Westcliffe Road
    BH4 8BG Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish87652740002
    GRAHAM, John Michael Denning
    11 Winton Drive
    G12 0PZ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Winton Drive
    G12 0PZ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish70764420001
    GRAY, James Richard
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108633480001
    GRAY, Robert William
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70366290004
    HARDINGE, Julian Alexander, Lord
    The Old Village Hall
    West Hill
    EX11 1TP Ottery St. Mary
    Devon
    Amministratore
    The Old Village Hall
    West Hill
    EX11 1TP Ottery St. Mary
    Devon
    British81516540001
    HILL, Robin Gordon
    14 Hillneuk Avenue
    Bearsden
    G61 3PZ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    14 Hillneuk Avenue
    Bearsden
    G61 3PZ Glasgow
    Lanarkshire
    British456630001
    HILL, Robin Gordon
    14 Hillneuk Avenue
    Bearsden
    G61 3PZ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    14 Hillneuk Avenue
    Bearsden
    G61 3PZ Glasgow
    Lanarkshire
    British456630001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish66183100001
    HUNTER, Robert Wishart
    Langside Gate Flat 1/6 266 Camphill Avenue
    G41 3AS Glasgow
    Amministratore
    Langside Gate Flat 1/6 266 Camphill Avenue
    G41 3AS Glasgow
    British22241340004
    JEYES, Peter Martin
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish5253210001
    LEITCH, Alan James Melville
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish37730320001
    MOORE, Andrew John
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Headlands Business Park
    Salisbury Road Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish157094220001
    NOTARANGELO, Pietro Raffaele
    25 Dalkeith Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2HQ Glasgow
    Amministratore
    25 Dalkeith Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2HQ Glasgow
    British32052400002
    SUGDEN, Christopher
    16 Westerton Drive
    FK9 4AX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    Amministratore
    16 Westerton Drive
    FK9 4AX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British79370940001
    SUGDEN, Christopher
    16 Westerton Drive
    FK9 4AX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    Amministratore
    16 Westerton Drive
    FK9 4AX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British79370940001
    WILLIAMSON, David Robert
    18 Victoria Crescent Road
    G12 9DB Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    18 Victoria Crescent Road
    G12 9DB Glasgow
    Lanarkshire
    British33103340002

    Chi sono le persone con controllo significativo di JOHN SMITH & SON GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Js Aspire Group Holdings Ltd
    2-8 Parkstone Road
    BH15 2PW Poole
    Towngate House
    England
    06 ott 2025
    2-8 Parkstone Road
    BH15 2PW Poole
    Towngate House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompany Registrar For England And Wales
    Numero di registrazione16690655
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    2-8 Parkstone Road
    BH15 2PW Poole
    Towngate House
    England
    20 feb 2023
    2-8 Parkstone Road
    BH15 2PW Poole
    Towngate House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04318012
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Peter Leigh Gray
    Headlands Business Park
    Salisbury Road, Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    England
    06 apr 2016
    Headlands Business Park
    Salisbury Road, Blashford
    BH24 3PB Ringwood
    Ash House
    Hampshire
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0