ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED

ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC008975
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    109 Douglas Street
    Glasgow
    G2 4HB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARBUCKLE, SMITH & COMPANY LIMITED01 dic 198701 dic 1987
    ARBUCKLE SMITH (HOLDINGS) LIMITED09 feb 191409 feb 1914

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Christopher Waters come amministratore

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 set 2010

    Stato del capitale al 09 set 2010

    • Capitale: GBP 450,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Exel Nominee No 2 Limited il 10 ago 2010

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Exel Secretarial Services Limited il 10 ago 2010

    2 pagineCH04

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione817717
    32524900007
    TAYLOR, Paul
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish105652320001
    EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1183615
    73807850002
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    BUSH, Nicholas James
    50 Chester Drive
    HA2 7PU Harrow
    Middlesex
    Segretario
    50 Chester Drive
    HA2 7PU Harrow
    Middlesex
    British69612020001
    MACRAE, James Norman
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    Segretario
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    British719840001
    MILLS, John Michael
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    Segretario
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    British193353200001
    SMITH, Nicholas Leigh
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British45625440002
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Segretario
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    British15165070001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69617780001
    BUMSTEAD, Jonathan Culver
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish72820970001
    ELLIS, Michael John
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    EnglandBritish133791220001
    GILES, Bruce Sinclair
    50a Warwick Place
    CV32 5DF Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    Amministratore
    50a Warwick Place
    CV32 5DF Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    British63973720001
    JOHNSTON, Geoffrey E F
    Upper Dunard
    Station Road
    G84 8LW Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    Amministratore
    Upper Dunard
    Station Road
    G84 8LW Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    British616920001
    KIRKBY, Peter
    Newnham View
    Newnham Green
    RG27 9AS Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Newnham View
    Newnham Green
    RG27 9AS Basingstoke
    Hampshire
    British22731280001
    MACRAE, James Norman
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish719840001
    OWER, James
    33 Cantley Crescent
    RG11 1NU Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    33 Cantley Crescent
    RG11 1NU Wokingham
    Berkshire
    British719860001
    PARKHILL, Thomas Cassidy
    22 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    22 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    British719870001
    RUSCH, Henry
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    Amministratore
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    British63973770001
    SMITH, Jamie Robert Mark
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish74084830002
    WATERS, Christopher Stephen
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish54969250001
    WILLIS, Nigel A R
    Nervelstone
    PA12 4DS Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Scotland
    Amministratore
    Nervelstone
    PA12 4DS Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Scotland
    British616900001
    WOODHAMS, Ernest J
    5 Rectory Close
    BN20 8AQ Eastbourne
    East Sussex
    England
    Amministratore
    5 Rectory Close
    BN20 8AQ Eastbourne
    East Sussex
    England
    British616890001

    ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of deposit account
    Creato il 02 lug 1987
    Consegnato il 14 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    £300,000 deposit account held by the company with investors in industry PLC.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 ago 1986
    Consegnato il 21 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease granted by the city of glasgow district council in favour of the company over 5 acres and 3 1/10TH parts of an acre.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 19 ott 1984
    Consegnato il 30 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due not exceeding £300,000
    Brevi particolari
    89/99 mitchell st. Glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 30 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 19 ott 1984
    Consegnato il 30 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Warehouse at ferry rd glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 30 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 18 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 12 ott 1984
    Consegnato il 26 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Steading of ground containing four hundred and eighty eight square yards or thereby lying on the west side of mitchell street, glasgow, in the city parish of glasgow and county of lanark that area of ground extending to one hundred and forty five square yards or thereby lying on the west side of mitchell street aforesaid and in said county.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 10 ott 1984
    Consegnato il 22 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plots of ground in glasgow first in mitchell street containing 488 sq yards and second plot 145 sq. Yards in mitchel street.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 07 giu 1983
    Consegnato il 22 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 07 giu 1983
    Consegnato il 20 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 06 mar 1980
    Consegnato il 11 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £201,686,77
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 4 acres and 37 1/100TH parts of an acre in paisley, renfrew.
    Persone aventi diritto
    • The District Council of Renfrew
    Transazioni
    • 11 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 09 dic 1975
    Consegnato il 12 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Endowment policy no.1378328 Dd. 19/9/75 insd. By commercial union assurance co. LTD. On life of geoffrey edward forshaw johnston for £150,000.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Union Assurance Co. LTD 1 Undershaft, London. EC3P 3DQ
    Transazioni
    • 12 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 dic 1975
    Consegnato il 05 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Advances made or to be made in terms of agreement at 24TH july & 1ST febry 1973
    Brevi particolari
    Lease of 5.3 acres in ferry rd. Glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Union Assurance Company LTD
    Transazioni
    • 05 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 19 giu 1975
    Consegnato il 08 lug 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Warehouse premises lying to the north of thornliebank road, lanark.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0