CAIRD GROUP LIMITED

CAIRD GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAIRD GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC010344
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAIRD GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAIRD GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAIRD GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A. CAIRD & SONS, PUBLIC LIMITED COMPANY21 apr 191921 apr 1919

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAIRD GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CAIRD GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    10 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF a 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 13 dic 2016

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 dic 2016

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 48 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Gibson Orr il 15 lug 2016

    2 pagineCH01

    Stato del capitale al 28 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    legacy

    2 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Consolidamento delle azioni al 24 giu 2016

    5 pagineSH02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Ordinary shares consolidated 24/06/2016
    RES13

    Nomina di Mr David Gibson Orr come amministratore in data 01 giu 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Philip Bernard Griffin-Smith come amministratore in data 01 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Toby Richard Woolrych come amministratore in data 01 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter George Dilnot come amministratore in data 01 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2016

    Stato del capitale al 06 mag 2016

    • Capitale: GBP 4,257,212
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 4,257,212
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2014

    Stato del capitale al 07 mag 2014

    • Capitale: GBP 4,257,212
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CAIRD GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    Segretario
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    British130189950001
    GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish130189950001
    ORR, David Gibson
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish203884240002
    EXCELL, Karen Alice
    103 St Olafs Road
    Fulham
    SW6 7DW London
    Segretario
    103 St Olafs Road
    Fulham
    SW6 7DW London
    British343060001
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    British34208920001
    GIBSON, Carolyn Ann
    Polo Barn
    Nairdwood Lane
    HP16 0QH Great Missenden
    Buckinghamshire
    Segretario
    Polo Barn
    Nairdwood Lane
    HP16 0QH Great Missenden
    Buckinghamshire
    British119043460001
    KAYE, Paul
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British3245340002
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Segretario
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    British18116420006
    ASHTON, John
    Hurst Villa
    Derbyshire Level
    SK13 9PT Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Hurst Villa
    Derbyshire Level
    SK13 9PT Glossop
    Derbyshire
    British574870001
    AVERILL, Michael Charles Edward
    Little Meadow Upton Road
    Dinton
    HP17 8UQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Meadow Upton Road
    Dinton
    HP17 8UQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish24913560002
    BROWN, Colin Andrew
    The Beeches George Road
    Milford On Sea
    SO41 0RS Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    The Beeches George Road
    Milford On Sea
    SO41 0RS Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish38101260002
    CLARK, James Anderson
    15 Earlspark Road
    Bieldside
    AB15 9BZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    15 Earlspark Road
    Bieldside
    AB15 9BZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish2203720001
    DILNOT, Peter George
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish166438690001
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Amministratore
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritish37289200002
    DRURY, Thomas Waterworth
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish/Canadian29701240002
    DYE, Kenneth Howard
    9 Greenfell Road
    HP9 2BP Beaconsfield
    Bucks
    Amministratore
    9 Greenfell Road
    HP9 2BP Beaconsfield
    Bucks
    British1368280001
    FARRELL, John Patrick
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    Amministratore
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    United KingdomBritish702300001
    HYNES, Stephen John
    6 The Hoe
    CM12 9XB Billericay
    Essex
    Amministratore
    6 The Hoe
    CM12 9XB Billericay
    Essex
    EnglandBritish70079680002
    JILLINGS, Charles David Owen
    Brockholt
    The Drive
    KT22 8QJ Tyrells Wood
    Surrey
    Amministratore
    Brockholt
    The Drive
    KT22 8QJ Tyrells Wood
    Surrey
    British45948970001
    LINACRE, Peter John
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish34646130002
    MASTERSON, Brian Rhys George, Professor
    Toad Hall Carlton Miniott
    YO7 4NJ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Toad Hall Carlton Miniott
    YO7 4NJ Thirsk
    North Yorkshire
    British3301580001
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Amministratore
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    EnglandBritish18116420006
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British343070001
    ROSS, Lionel Jack
    15 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    British1338810002
    SURCH, Christopher
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138144350001
    WEIR, David Thomas
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    UkBritish33621820001
    WELHAM, Fraser Andrew Norton
    Pennard
    Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pennard
    Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    UkBritish105268510002
    WILCOX, David
    4 Trelawne Drive
    GU6 8BS Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    4 Trelawne Drive
    GU6 8BS Cranleigh
    Surrey
    British1233030001
    WOOLRYCH, Toby Richard
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish116504630005

    CAIRD GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 09 apr 1999
    Consegnato il 23 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects registered as title number LAN1936, LAN50022, LAN51722 and LAN70845.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 22 ott 1997
    Consegnato il 11 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 14 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 22 ott 1997
    Consegnato il 11 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 14 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 22 dic 1992
    Consegnato il 31 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 14 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 18 feb 1991
    Consegnato il 05 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects north of greengairs rd greengairs riggend lan 1936 hartloup riggend lan 50022 hartloup riggend lan 51722 berryhill cottage riggend lan 70430 berryhill cottage riggend lan 70845.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Debenture creating a fixed and floating charge
    Creato il 27 set 1988
    Consegnato il 13 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 13 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1988
    Consegnato il 08 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Buildings south east side of commercial road, south shields.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 08 ott 1987
    Consegnato il 19 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property 6 errol st, peterhead.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property 23 high st, perth 12/14 george st, perth.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property 129 king st, castle douglas.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property, 142 main st, cambuslang, lanarkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property 21 high st & 4 & 6 george st, perth.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property 64 high st, fort william.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heritable property at 19 hopetoun st. Bathgate.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 set 1987
    Consegnato il 15 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    56, 58 & 60 guildford st, chertsey.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 set 1987
    Consegnato il 15 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    8 & 10 stanley st, liverpool.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1986
    Consegnato il 31 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Commercial road south shields co durham described in a lease.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1986
    Consegnato il 31 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    36 & 37 the town and garage at the rear of 10 & 12 london road, enfield.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1986
    Consegnato il 31 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    71 & 71A kings road, chelsea, london SW3.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1986
    Consegnato il 31 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    8/10 stanley street liverpool.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 19 ago 1983
    Consegnato il 30 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    39 bell street st andrews.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 19 ago 1983
    Consegnato il 30 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    21- 25- reform street, dundee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 04 ago 1983
    Consegnato il 15 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Letter of offset
    Creato il 11 mag 1983
    Consegnato il 26 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by caird retail LTD
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Fourth supplementary bond of cash credit & disposition in security & addendum to agreement
    Creato il 31 ott 1968
    Consegnato il 04 nov 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £177,500
    Brevi particolari
    Capital, stocks, property funds assets and profits, shop premises and 17 policies of assurance on life.
    Persone aventi diritto
    • The Scottish Life Assurance Company
    Transazioni
    • 04 nov 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 13 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04s)
    • 01 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    CAIRD GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 dic 2016Inizio della liquidazione
    24 feb 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0