ROK ESTATES LIMITED

ROK ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROK ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC013685
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROK ESTATES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova ROK ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    151 St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROK ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CITY ESTATES LIMITED26 mag 192526 mag 1925

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROK ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ROK ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Julian Turnbull come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sandra Al-Kordi come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2010

    Stato del capitale al 26 mag 2010

    • Capitale: GBP 171,666
    SH01

    Nomina di Mr Julian Patrick Turnbull come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Sandra Joan Al-Kordi come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Julian Turnbull come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ross Christie come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Garvis Snook come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    21 pagine410(Scot)

    Modifiche alla garanzia mobiliare 53

    10 pagine466(Scot)

    Modifiche alla garanzia mobiliare 50

    13 pagine466(Scot)

    Modifiche alla garanzia mobiliare 51

    16 pagine466(Scot)

    legacy

    14 pagine410(Scot)

    Modifiche alla garanzia mobiliare 52

    10 pagine466(Scot)

    legacy

    8 pagine410(Scot)

    legacy

    13 pagine410(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    25 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ROK ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AL-KORDI, Sandra Joan
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    150343640001
    LEICESTER, John William
    35 Newton Road
    GU14 8BN Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    35 Newton Road
    GU14 8BN Farnborough
    Hampshire
    British1011450001
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    BritishFinance Director5814050002
    TITHERIDGE, Timothy John
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Segretario
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    BritishDirector80101260001
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Segretario
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    WHITEHEAD, John
    4 Prospect Terrace
    HG5 0HR Knaresborough
    North Yorkshire
    Segretario
    4 Prospect Terrace
    HG5 0HR Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishSecretary546830001
    BAILEY, Michael William John
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    Amministratore
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    BritishDirector104839850001
    BRYAN, Richard Hugh
    Abbey Place
    Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Abbey Place
    Virginia Water
    Surrey
    BritishCompany Director1011430001
    CHRISTIE, Ross Arneil
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    EnglandBritishFinancial Controller106468680002
    CRAIG, Brian Archibald
    The Round House
    High Oak Road
    SG12 7PR Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Round House
    High Oak Road
    SG12 7PR Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCs71144000001
    GIDNEY, David Guy
    Border Hill House
    Dippenhall
    GU10 5DU Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Border Hill House
    Dippenhall
    GU10 5DU Farnham
    Surrey
    BritishSolicitor63635850001
    GLOVER, Edward Douglas
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    Amministratore
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    United KingdomBritishBank Director121380002
    HOLE, Nicholas Ian
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    Amministratore
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    United KingdomBritishDirector128347270001
    JORDAN, Rodney Beeching
    Bucehayes Farm
    Cotleigh
    EX14 9JA Honiton
    Devon
    Amministratore
    Bucehayes Farm
    Cotleigh
    EX14 9JA Honiton
    Devon
    BritishDirector76263960001
    KAY, Mark Russell
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    Amministratore
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    BritishDirector1472550001
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    BritishFinance Director5814050002
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Crofts End
    1 Cloister Way
    CV32 6QE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Crofts End
    1 Cloister Way
    CV32 6QE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant5814050001
    MACKEY, Paul Emmanuel
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    IrishBank Director11264820004
    MALLINSON, David John
    Whistlers Canada Road
    West Wellow
    SO51 6DD Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Whistlers Canada Road
    West Wellow
    SO51 6DD Romsey
    Hampshire
    BritishCompany Director24343760001
    REARDON, David James
    Slights Cottage Ings Lane
    East Cottingwith
    YO4 4TW York
    Amministratore
    Slights Cottage Ings Lane
    East Cottingwith
    YO4 4TW York
    BritishProperty Manager50574050001
    SNOOK, Garvis David
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    Amministratore
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    EnglandBritishDirector70647210004
    TEMPEST, Philip Anthony
    Oaks Ridge House 53a Oaks Road
    Great Glen
    LE8 9EG Leicester
    Amministratore
    Oaks Ridge House 53a Oaks Road
    Great Glen
    LE8 9EG Leicester
    BritishDirector36898820003
    TITHERIDGE, Timothy John
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    BritishDirector80101260001
    TURNBULL, Julian Patrick
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Amministratore
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    EnglandEnglishCompany Secretary11548360002

    ROK ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture and guarantee
    Creato il 11 mar 2009
    Consegnato il 31 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Temple Trustees Limited
    Transazioni
    • 31 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 31 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 11 mar 2009
    Consegnato il 28 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Temple Trustees Limited
    Transazioni
    • 28 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 28 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Debenture and guarantee
    Creato il 11 mar 2009
    Consegnato il 26 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 31 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 11 mar 2009
    Consegnato il 26 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 31 mar 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Third party legal charge
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 22 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over plot 4400, solent business park, fareham, hampshire; fixed charge over assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Charge over shares
    Creato il 20 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The shares.
    Persone aventi diritto
    • Mckay Securities PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Charge over shares
    Creato il 20 giu 1997
    Consegnato il 27 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All shares.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transazioni
    • 27 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of assignment
    Creato il 13 dic 1996
    Consegnato il 30 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Rights,title and interest to one third of the entitlement.
    Persone aventi diritto
    • Eastern Rivers Limited
    Transazioni
    • 30 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1995
    Consegnato il 12 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    5 carlton crescent, southampton, registered under title number hp 101992, together with all covenants and rights, plant, machinery etc., and goodwill in relation to that property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 16 ago 1995
    Consegnato il 31 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    First legal mortgage on plot 300, ancells business park, fleet, hampshire, registered under title number hp 321407, assignment of the benefit of all leases on that property, and first fixed charges on goodwill and any vat relating to the property.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 31 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 21 lug 1995
    Consegnato il 04 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 23 mag 1995
    Consegnato il 12 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plot 300, ancells business park, fleet, hampshire...... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 12 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 21 mar 1995
    Consegnato il 10 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1) legal mortgage on the sun inn, town quay, southampton, registered under title number HP454183 2) assignment of security on all present and future derivative leases 3) fixed charge on goodwill 4) fixed charge on rights in any monies representing repayment by custon & excise of vat.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 10 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Charge
    Creato il 30 gen 1995
    Consegnato il 16 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    See continuation sheet no.2 On c/hse microfiche.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transazioni
    • 16 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 26 gen 1995
    Consegnato il 15 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    See scheldule 2 on c/hse microfiche.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Property Investments Limited
    Transazioni
    • 15 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1994
    Consegnato il 16 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    5 carlton crescent, southampton and registered at H.M. land registry HP101992.
    Persone aventi diritto
    • Clerical Medical and General Life Assurance Society
    Transazioni
    • 16 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 1992
    Consegnato il 24 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    5 carlton crescent southampton,hp 101992.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 gen 1992Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 09 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 1991
    Consegnato il 30 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 2 haywards business centre new lane havant hampshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 28 mar 1990
    Consegnato il 04 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Freehold property known as or being land having frontage to brunel road and telford road, salisbury, wiltshire comprising of 2.6 acres.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage deed
    Creato il 08 set 1989
    Consegnato il 25 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000
    Brevi particolari
    5 carlton crescent southampton hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Alliance & Leicester Building Society
    Transazioni
    • 25 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1989
    Consegnato il 06 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Freehold property west side of castle way southampton hampshire title no hp 293934.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    First legal charge
    Creato il 21 feb 1989
    Consegnato il 06 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Aerogan works, newmans lane, alton in hampshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1989
    Consegnato il 06 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    385 wimbourne rd., Winton, bournemouth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 1989
    Consegnato il 16 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    5 carlton crescent, southampton, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1988
    Consegnato il 13 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piece of land on north side of the hundred ramsey, hampshire plus shop at 28 the hundred ramsey.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0