LACTALIS MCLELLAND LIMITED

LACTALIS MCLELLAND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLACTALIS MCLELLAND LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC014583
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    • Produzione di latte e panna liquidi (10511) / Industrie manifatturiere
    • Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova e oli e grassi commestibili (46330) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (46390) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Creamery
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A. MCLELLAND & SON LIMITED29 apr 192729 apr 1927

    Quali sono gli ultimi bilanci di LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al16 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma30 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al16 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mr Jean-Yves Bernard Francois Haagen come amministratore in data 27 nov 2024

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    73 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michel Peslier come amministratore in data 30 apr 2024

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Naigee Gopal il 06 giu 2024

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michel Peslier il 06 giu 2024

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael David John Chatters il 06 giu 2024

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michel Peslier il 08 gen 2024

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Ms Marie Besnier come persona con controllo significativo il 08 gen 2024

    2 paginePSC04

    Modifica dei dettagli di Mr Emmanuel Besnier come persona con controllo significativo il 08 gen 2024

    2 paginePSC04

    Modifica dei dettagli di Mr Jean-Michel Besnier come persona con controllo significativo il 08 gen 2024

    2 paginePSC04

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Naigee Gopal il 08 gen 2024

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael David John Chatters il 08 gen 2024

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    72 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    64 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2022 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    61 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michel Peslier il 23 giu 2021

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Prism Cosec Limited il 26 mag 2021

    1 pagineCH04

    Cessazione della carica di Daniel Marie Jaouen come amministratore in data 09 nov 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2019

    56 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Michael David John Chatters come amministratore in data 01 giu 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRISM COSEC LIMITED
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    Yeoman Way
    BN99 3HH Worthing
    Highdown House
    West Sussex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05533248
    116519070002
    CHATTERS, Michael David John
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector270257040001
    GOPAL, Naigee
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director136661790003
    HAAGEN, Jean-Yves Bernard Francois
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    FranceLuxembourgerDirector331112930001
    IRVINE, Agnes Wilson
    Trynlaw House
    KA1 5PY Symington
    Ayrshire
    Segretario
    Trynlaw House
    KA1 5PY Symington
    Ayrshire
    British724410001
    POWELL-COOK, Neale Alan
    Babylon Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6UY Tadworth
    23 Kingswood Grange
    Surrey
    Segretario
    Babylon Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6UY Tadworth
    23 Kingswood Grange
    Surrey
    BritishFinance Director129374200001
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    42-50 Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    Ashley Park House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    42-50 Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    Ashley Park House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneOC309455
    131429630001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    34893920004
    BOUISSET, Frederic
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    FrenchBusiness Director119026730001
    BOYER, Jean-Francois
    2 Impasse De La Vigne
    53950 Niafles-Louverne
    France
    Amministratore
    2 Impasse De La Vigne
    53950 Niafles-Louverne
    France
    FrenchBusiness Director119034590001
    CAIRNS, Joseph Thomas Francis
    14 Fernhill Road
    PH2 7BE Perth
    Amministratore
    14 Fernhill Road
    PH2 7BE Perth
    ScotlandUnited KingdomFinance Director44890480002
    CEYRAC, Regis
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    FrenchBusiness Director119024980002
    CLEMENT, Thierry Thomas Yves Marie
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    FranceFrenchDirector160882180001
    DEGLI ANTONI, Filippo
    3 Kensington Road
    G12 9LE Glasgow
    Amministratore
    3 Kensington Road
    G12 9LE Glasgow
    ItalianCompany Director121895120001
    GILMOUR, Robin Moffat
    14 Mosspark Avenue
    Milngavie
    G62 8NL Glasgow
    Amministratore
    14 Mosspark Avenue
    Milngavie
    G62 8NL Glasgow
    United KingdomBritishCheese Factor19955210001
    GUERIN, Yvon Phillippe
    Princess Way 2nd Floor
    RH1 1QG Redhill
    3
    Surrey
    Uk
    Amministratore
    Princess Way 2nd Floor
    RH1 1QG Redhill
    3
    Surrey
    Uk
    FranceFrenchDirector160882060001
    IRVINE, Douglas Forbes
    Alloway Cottage
    Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayr
    Amministratore
    Alloway Cottage
    Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayr
    BritishCheese Merchant104622570001
    IRVINE, Hugh Mclelland
    Trynlaw House
    KA1 5PY Symington
    Ayrshire
    Amministratore
    Trynlaw House
    KA1 5PY Symington
    Ayrshire
    ScotlandBritishCheese Factor724420001
    IRVINE, John Alastair
    The Coyle House
    KA6 5JY Sundrum
    Ayr
    Amministratore
    The Coyle House
    KA6 5JY Sundrum
    Ayr
    BritishCheese Factor104622710001
    JAOUEN, Daniel Marie
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    FrenchBusiness Director92857270004
    KLEIN, Olivier Pierre
    3 Princess Way
    RH1 1QG Redhill
    2nd Floor
    Surrey
    Amministratore
    3 Princess Way
    RH1 1QG Redhill
    2nd Floor
    Surrey
    FranceFrenchDirector147525340001
    LEONARD, Michel
    8 Rue Bellavoine
    78230 Le Pecq
    France
    Amministratore
    8 Rue Bellavoine
    78230 Le Pecq
    France
    FranceFrenchBusiness Director106951450001
    LEVANTAL, Thierry
    32 Rue Magenta
    53000 Laval
    France
    Amministratore
    32 Rue Magenta
    53000 Laval
    France
    FrenchGeneral Counsel104820780001
    MCGREGOR, James
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    BritishCompany Director91552120002
    MEAUDRE, Hugues Bernard
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    EnglandFrenchDirector248936530001
    PESLIER, Michel
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    65-71 London Road
    RH1 1LQ Redhill
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    FranceFrenchAudit & Legal General Manager133713430002
    POWELL-COOK, Neale Alan
    Babylon Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6UY Tadworth
    23 Kingswood Grange
    Surrey
    Amministratore
    Babylon Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6UY Tadworth
    23 Kingswood Grange
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director129374200001
    SALA, Antonio
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    FranceItalianDeputy General Manager Corporate180725860001
    SAUVAGEOT, Patrick Francois
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    Amministratore
    60 High Street
    Redhill
    RH1 1SH Surrey
    Red Central
    England
    England
    FranceFrenchBusiness Director170850400001
    SMITH, Andrew James
    Quayside
    6 Waters Edge
    ME15 6SG Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Quayside
    6 Waters Edge
    ME15 6SG Maidstone
    Kent
    EnglandBritishBusiness Director102736440001
    TAYLOR, Mark Garfield
    High Street
    Red Central
    RH1 1SH Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    Red Central
    RH1 1SH Redhill
    60
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director189741560001
    ZADRO, Mato
    Princess Way
    2nd Floor
    RH1 1QG Redhill
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Princess Way
    2nd Floor
    RH1 1QG Redhill
    3
    Surrey
    United Kingdom
    FranceCroatianBusiness Director Rest Of The World170850520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LACTALIS MCLELLAND LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Emmanuel Besnier
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    The Creamery
    06 apr 2016
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    The Creamery
    No
    Nazionalità: French
    Paese di residenza: France
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr Jean-Michel Besnier
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    The Creamery
    06 apr 2016
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    The Creamery
    No
    Nazionalità: French
    Paese di residenza: France
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Ms Marie Besnier
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    The Creamery
    06 apr 2016
    Commerce Road
    DG9 7DA Stranraer
    The Creamery
    No
    Nazionalità: French
    Paese di residenza: France
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0