HANOVER FOUR LIMITED

HANOVER FOUR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHANOVER FOUR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC015674
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HANOVER FOUR LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova HANOVER FOUR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HANOVER FOUR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THOMSON BROTHERS LTD.06 giu 199406 giu 1994
    THOMSON BROTHERS (KIRKCALDY) LIMITED16 ago 192916 ago 1929

    Quali sono gli ultimi bilanci di HANOVER FOUR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 feb 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per HANOVER FOUR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Simon Terence Douglas come amministratore in data 14 nov 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Hedley Bowcock come amministratore in data 14 nov 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ago 2011

    Stato del capitale al 15 ago 2011

    • Capitale: GBP 21,412
    SH01

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Hedley Bowcock come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Jayne Fearn come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 25 feb 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Marks come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Luminar Leisure Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2009

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 28 feb 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 01 mar 2007

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 02 mar 2006

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di HANOVER FOUR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FEARN, Jayne
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    158739440001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Amministratore
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03802937
    152179970001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Segretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Segretario
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Segretario
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Segretario
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Segretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Amministratore
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    COOK, John
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    Amministratore
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    ScotlandBritish1388150003
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    GARVIE, David Campbell
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    British4668490001
    GUTTERIDGE, Timothy Roy
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    British6050070003
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    JUDGE, Michael
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    Amministratore
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    British653260001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MALCOLM, Alexander Ramsay
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    Amministratore
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    ScotlandBritish66254130001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    PRENTICE, William
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    British653270001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002

    HANOVER FOUR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 07 feb 1995
    Consegnato il 23 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Letter of offset
    Creato il 16 ago 1982
    Consegnato il 31 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by t s forster & sons LTD
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Letter of offset
    Creato il 19 mar 1982
    Consegnato il 06 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by park naval engineering LTD
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Letter of offset
    Creato il 09 feb 1981
    Consegnato il 13 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by robt. Balbirnie & company LTD and/or another
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Letter of offset
    Creato il 13 mar 1979
    Consegnato il 22 mar 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by fife forester LTD and/or others
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by bank of scotland in name of thomson brothers (kirkcaldy) LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 mar 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0