HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)

HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società SC016819
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
    • Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    Indirizzo della sede legale
    Hannah Research Institute Hannah Research Park
    Mauchline Road
    KA6 5HL Ayr
    Ayrshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HANNAH RESEARCH INSTITUTE FOR STUDIES RELATING TO THE PRODUCTION AND UTILIZATION OF MILK (THE)07 mag 193207 mag 1932
    HANNAH RESEARCH INSTITUTE FOR STUDIES RELATING TO THE PRODUCTION AND UTILIZATION OF MILK (THE)07 mag 192207 mag 1922

    Quali sono gli ultimi bilanci di HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The company has been converted into a scio 15/01/2014
    RES13

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    16 pagineAA

    Nomina di Mr John Alexander Ross come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Professor Peter Henry Holmes come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Thomas Bryson come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02s

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di David Collier come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2010, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    9 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Dr David Andrew Winton Collier il 20 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Dorothy Mary Dawson il 20 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Professor Lawrence Trevelyan Weaver il 20 ago 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    5 pagineMG01s

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    15 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Sir Alastair Muir Russell il 09 nov 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNLOP, James Anthony Kelly
    48 Brisbane Road
    KA30 8NJ Largs
    Ayrshire
    Segretario
    48 Brisbane Road
    KA30 8NJ Largs
    Ayrshire
    British986690002
    ARMOUR, James
    4b Towans Court
    KA9 2AY Prestwick
    Ayrshire
    Amministratore
    4b Towans Court
    KA9 2AY Prestwick
    Ayrshire
    United KingdomBritishProfessor (Retired)44140130004
    DAWSON, Dorothy Mary
    Abbey House
    KA5 6AP Mauchline
    Ayrshire
    Amministratore
    Abbey House
    KA5 6AP Mauchline
    Ayrshire
    United KingdomBritishRetired745290001
    HOLMES, Peter Henry, Professor
    Barclay Drive
    G84 9RD Helensburgh
    2
    Dunbartonshire
    Scotland
    Amministratore
    Barclay Drive
    G84 9RD Helensburgh
    2
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritishRetired Professor32939010001
    ROSS, John Alexander, Doctor
    Portpatrick
    DG9 8TN Stranraer
    Auchenrea Cottage
    Wigtownshire
    Scotland
    Amministratore
    Portpatrick
    DG9 8TN Stranraer
    Auchenrea Cottage
    Wigtownshire
    Scotland
    ScotlandUkFarmer181991310001
    RUSSELL, Alastair Muir, Sir
    Rothesay Place
    EH3 7SL Edinburgh
    11a
    Scotland
    Amministratore
    Rothesay Place
    EH3 7SL Edinburgh
    11a
    Scotland
    ScotlandBritishConsultant141161130001
    SUCKLING, Keith Edward, Doctor
    291 Knightsfield
    AL8 7NH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    291 Knightsfield
    AL8 7NH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishScientist8889260001
    WEAVER, Lawrence Trevelyan, Professor
    4 Huntly Gardens
    G12 9AS Glasgow
    Amministratore
    4 Huntly Gardens
    G12 9AS Glasgow
    ScotlandBritishProfessor78438550001
    MCCANCE, Neil Anderson Davis
    The Hannah Research Institute
    KA6 5HL Ayr
    Segretario
    The Hannah Research Institute
    KA6 5HL Ayr
    British611470001
    SCOTT, Margaret Wishart
    Pleasantfield
    Browns Crescent
    KA6 5EB Annbank
    Ayrshire
    Segretario
    Pleasantfield
    Browns Crescent
    KA6 5EB Annbank
    Ayrshire
    British126807270001
    BRYSON, Thomas Steele
    1 Cairn Crescent
    Alloway
    KA7 4PP Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    1 Cairn Crescent
    Alloway
    KA7 4PP Ayr
    Ayrshire
    United KingdomBritishChartered Accountant143460001
    BRYSON, Thomas Steele
    1 Cairn Crescent
    Alloway
    KA7 4PP Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    1 Cairn Crescent
    Alloway
    KA7 4PP Ayr
    Ayrshire
    United KingdomBritishC.A.143460001
    CALDWELL, John
    Kelk Cottage
    Annandale Crosshouse
    KA2 0AH Kilmarnock
    Amministratore
    Kelk Cottage
    Annandale Crosshouse
    KA2 0AH Kilmarnock
    BritishFarmer417330001
    CAMPBELL, Andrew Robertson
    Cuil
    DG7 1QB Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Amministratore
    Cuil
    DG7 1QB Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    BritishFarmer45766920001
    COGGINS, John Richard, Professor
    5 Chapelton Gardens
    Bearsden
    G61 2DH Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    5 Chapelton Gardens
    Bearsden
    G61 2DH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishUniversity Professor698000001
    COLLIER, David Andrew Winton, Dr
    19 Monument Road
    KA7 2RL Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    19 Monument Road
    KA7 2RL Ayr
    Ayrshire
    United KingdomBritishConsultant Physician100209740001
    DAVIES, Graeme John, Professor Sir
    Principals Office The University
    G12 8QG Glasgow
    Amministratore
    Principals Office The University
    G12 8QG Glasgow
    United KingdomBritishUniversity Principal46842590002
    EVANS, Fraser Ross
    Drumgarron House
    Penkiln Garlieston
    DG8 8AB Newton Stewart
    Wigtownshire
    Amministratore
    Drumgarron House
    Penkiln Garlieston
    DG8 8AB Newton Stewart
    Wigtownshire
    BritishFarmer611520001
    FERGUSON, William James
    Rothiebrisbane
    Fyvie
    AB5 8LE Turriff
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Rothiebrisbane
    Fyvie
    AB5 8LE Turriff
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishFarmer235610001
    FRASER, William Kerr, Sir
    Principal's Lodging 12 The Square
    University Of Glasgow
    G12 8QQ Glasgow
    Amministratore
    Principal's Lodging 12 The Square
    University Of Glasgow
    G12 8QQ Glasgow
    BritishPrincipal Of Glasgow University611480001
    GILLESPIE, John Spence
    5 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    Amministratore
    5 Boclair Road
    Bearsden
    G61 2AE Glasgow
    BritishProfessor Of Immunology611500001
    HAMILTON, Loudon Pearson
    Old Lyne Station
    EH45 8NP Peebles
    Scottish Borders
    Amministratore
    Old Lyne Station
    EH45 8NP Peebles
    Scottish Borders
    BritishRetired54343480002
    HARDING, Frank
    8 Sharon Close
    KT23 3LB Bookham
    Surrey
    Amministratore
    8 Sharon Close
    KT23 3LB Bookham
    Surrey
    BritishTechnical Director Of Milk Marketing Board76029320001
    LAIDLAW, John Robert
    5 Cardell
    PA18 6AD Wemyss Bay
    Renfrewshire
    Amministratore
    5 Cardell
    PA18 6AD Wemyss Bay
    Renfrewshire
    ScotlandBritishDirector124452500001
    MCGHIE, Christopher Halliday
    1 Vendace Drive
    Lochmaben
    DG11 1QN Lockerbie
    Amministratore
    1 Vendace Drive
    Lochmaben
    DG11 1QN Lockerbie
    BritishCompany Director1316350001
    MCMYN, John
    Blawearie Kirkhouse
    Kirkbean
    DG2 8DW Dumfries
    Amministratore
    Blawearie Kirkhouse
    Kirkbean
    DG2 8DW Dumfries
    ScotlandBritishFarmer866260002
    MURRAY, Maxwell, Professor
    21 Ledcameroch Road
    Bearsden
    G61 4AE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    21 Ledcameroch Road
    Bearsden
    G61 4AE Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishProfessor Of Veterinary Medici264142990001
    PARROTT, Delphine Mary Vera, Professor
    13 Bellshaugh Place
    G12 0PF Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    13 Bellshaugh Place
    G12 0PF Glasgow
    Lanarkshire
    BritishProfessor Of Bacteriology611490001
    WRIGHT, Norman Gray, Professor
    50 Kilmardinny Crescent
    Bearsden
    G61 3NR Glasgow
    Amministratore
    50 Kilmardinny Crescent
    Bearsden
    G61 3NR Glasgow
    BritishProfessor Of Vetinary Anatomy36016720001

    HANNAH RESEARCH INSTITUTE(THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 22 gen 2010
    Consegnato il 02 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Kirkhill farmhouse hannah research park st quivox ayr.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 02 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 01 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0