HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)

HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC017049
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)?

    • (1712) /

    Dove si trova HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Tenon Recovery
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di riunione finale dei creditori

    9 pagine4.17(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 16 dic 2008

    LRESEX

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    3 pagine410(Scot)

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 24 feb 2007

    19 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    7 pagine410(Scot)

    legacy

    7 pagine410(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Banking documents 31/10/06
    RES13

    legacy

    16 pagine155(6)a

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    legacy

    2 pagine419a(Scot)

    Chi sono gli amministratori di HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRYARS, Sian
    Mill Road
    Seaton
    LE15 9HX Oakham
    Seaton Mill
    Leicestershire
    Segretario
    Mill Road
    Seaton
    LE15 9HX Oakham
    Seaton Mill
    Leicestershire
    British128642280001
    BRYARS, David Andrew
    Seaton Mill
    Mill Road, Seaton
    LE15 9HX Rutland
    Amministratore
    Seaton Mill
    Mill Road, Seaton
    LE15 9HX Rutland
    EnglandBritish37380810006
    ANDERSON, John Alexander
    Rosewood
    TD7 4EU Selkirk
    Segretario
    Rosewood
    TD7 4EU Selkirk
    British195360001
    BRYARS, David Andrew
    Seaton Mill
    Mill Road, Seaton
    LE15 9HX Rutland
    Segretario
    Seaton Mill
    Mill Road, Seaton
    LE15 9HX Rutland
    British37380810006
    CARRUTHERS, June
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    Segretario
    Burnside House Maxwell Place
    DG13 0DY Langholm
    Dumfriesshire
    British50519150001
    CHARLTON, John Joseph
    Hunterheck
    DG10 9LE Moffat
    Dumfriesshire
    Segretario
    Hunterheck
    DG10 9LE Moffat
    Dumfriesshire
    British42065600002
    DUNBAR, Jennifer Mary
    47 Brunstock Close
    Lowry Hill
    CA3 0HL Carlisle
    Cumbria
    Segretario
    47 Brunstock Close
    Lowry Hill
    CA3 0HL Carlisle
    Cumbria
    British177390001
    FERRIE, David Francis
    68 Lansdowne Crescent
    CA3 9EP Carlisle
    Segretario
    68 Lansdowne Crescent
    CA3 9EP Carlisle
    British38674150001
    FERRIE, David Francis
    68 Lansdowne Crescent
    CA3 9EP Carlisle
    Segretario
    68 Lansdowne Crescent
    CA3 9EP Carlisle
    British38674150001
    MCINTOSH, Colin William
    10 Pentland Drive
    Bishopbriggs
    G64 1XT Glasgow
    Segretario
    10 Pentland Drive
    Bishopbriggs
    G64 1XT Glasgow
    British35193190001
    AINSLIE, James Thomas Heard
    Birkindale
    17 Whitaside
    DG13 0JS Langholm
    Dumfriesshire
    Amministratore
    Birkindale
    17 Whitaside
    DG13 0JS Langholm
    Dumfriesshire
    British174030001
    ANDERSON, John Alexander
    Rosewood
    TD7 4EU Selkirk
    Amministratore
    Rosewood
    TD7 4EU Selkirk
    British195360001
    BIRRELL, Colin
    The Shaw House
    Boreland
    DG11 2LG Lockerbie
    Dumfriesshire
    Amministratore
    The Shaw House
    Boreland
    DG11 2LG Lockerbie
    Dumfriesshire
    British27229490003
    CHARLTON, John Joseph
    Hunterheck
    DG10 9LE Moffat
    Dumfriesshire
    Amministratore
    Hunterheck
    DG10 9LE Moffat
    Dumfriesshire
    British42065600002
    DAY, Philip Edward
    Hayton Hall
    Edmund Castle Estate, Corby Hill
    CA4 8QD Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Hayton Hall
    Edmund Castle Estate, Corby Hill
    CA4 8QD Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritish46992150006
    ELLIOT, John Johnstone
    25 Whitaside
    DG13 0JS Langholm
    Dumfriesshire
    Amministratore
    25 Whitaside
    DG13 0JS Langholm
    Dumfriesshire
    United KingdomBritish177990001
    HAYWARD, Graham John
    The Hermitage Galahill
    TD8 6QE Jedburgh
    Roxburghshire
    Amministratore
    The Hermitage Galahill
    TD8 6QE Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritish51640001
    HOUSTON, David Oliver
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    Amministratore
    72 Royal Gardens, Sovereigns Gate
    Bothwell
    G71 8SY Glasgow
    ScotlandBritish75910100005
    REID, James Alexander
    15 Pirn Road
    EH44 6HG Innerleithen
    Peeblesshire
    Amministratore
    15 Pirn Road
    EH44 6HG Innerleithen
    Peeblesshire
    British195390001
    ROBERTSON, Arthur Armstrong
    Bridgewood
    Victoria Crescent
    TD7 5DE Selkirk
    Borders
    Amministratore
    Bridgewood
    Victoria Crescent
    TD7 5DE Selkirk
    Borders
    British33692330001
    SMITH, John Royston
    5 Towerburn
    Denholm
    TD9 8TB Hawick
    Roxburghshire
    Amministratore
    5 Towerburn
    Denholm
    TD9 8TB Hawick
    Roxburghshire
    British75644300001
    SMITH, John Royston
    1 Norfield
    Fixby
    HD2 2HD Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Norfield
    Fixby
    HD2 2HD Huddersfield
    West Yorkshire
    British1213060001
    STEVENSON, David Deas
    Springhill
    DG13 0LP Langholm
    Dumfriesshire
    Amministratore
    Springhill
    DG13 0LP Langholm
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish22838300001
    TAYLOR, Anthony Bichard
    The Coach House
    Bowden
    TD6 0SS Melrose
    Roxburghshire
    Amministratore
    The Coach House
    Bowden
    TD6 0SS Melrose
    Roxburghshire
    ScotlandBritish195370006
    WHITAKER, Alec
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    Amministratore
    Batt House
    Crosby On Eden
    CA6 4RA Carlisle
    EnglandBritish60593850003

    HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 08 feb 2008
    Consegnato il 22 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Edinburgh Woollen Mill (Group) Limited
    Transazioni
    • 22 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 08 feb 2008
    Consegnato il 22 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Gibson & Lumgair (Scotland) Limited
    Transazioni
    • 22 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 07 nov 2006
    Consegnato il 28 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    87 bongate, jedburgh.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 07 nov 2006
    Consegnato il 28 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heather mills, selkirk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 23 mar 2005
    Consegnato il 04 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects known as heather mills, selkirk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 mar 2005
    Consegnato il 04 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects known as the whinfield mills, selkirk extending to 16,543 square yards.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 mar 2005
    Consegnato il 04 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piece of ground lying on the northwest side of bongate, jedburgh with the warehouse premises erected thereon known as 87 bongate, jedburgh.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 06 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 15 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 27 dic 2002
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    87 bongate, jedburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Heather mills, selkirk.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Whinefield mill, selkirk.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 15 nov 2002
    Consegnato il 28 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    õLegal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 ago 2001
    Consegnato il 13 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    87 bongate, jedburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 ago 2001
    Consegnato il 10 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects in the millheaugh in the burgh and county of selkirk extending to 16,543 square yards.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 ago 2001
    Consegnato il 10 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Portion of millheugh of selkirk on the north of the railway station in the burgh and parish and county of selkirk.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 25 lug 2001
    Consegnato il 07 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    ;Egal mortgage over property (of which there is none); fixed charges over assets;floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 12 nov 1990
    Consegnato il 23 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    HEATHER MILLS COMPANY LIMITED (THE) ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2010Data di scioglimento
    16 dic 2008Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0