MERSON SIGNS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MERSON SIGNS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC020547 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MERSON SIGNS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova MERSON SIGNS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow Scotland |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MERSON SIGNS LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 01 ott 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MERSON SIGNS LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 31 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MERSON SIGNS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio consolidato redatto al 01 ott 2023 | 34 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Donna Wilson come amministratore in data 14 ago 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Scott Kirkwood Poole come amministratore in data 14 ago 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 02 ott 2022 | 34 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2023 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Melissa Milne come amministratore in data 16 mag 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Suzanne Murray come amministratore in data 16 mag 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 29 set 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 28 set 2022
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Athanasios Theodorou come amministratore in data 15 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 03 ott 2021 | 37 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Athanasios Theodorou come amministratore in data 15 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Scott Kirkwood Poole come amministratore in data 15 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 20 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 30 set 2020 | 47 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MERSON SIGNS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGUS, Roderick Ian Arthur | Segretario | 627 Shields Road G41 2RT Glasgow 2/1 | British | Director | 25836970003 | |||||
ANGUS, Roderick Ian Arthur | Amministratore | 627 Shields Road G41 2RT Glasgow 2/1 | Scotland | British | Chartered Accountant | 25836970003 | ||||
HENDERSON, Andrew | Amministratore | Wentworth East Kilbride G74 5PY Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 139703740003 | ||||
MCMURRAY, Gavin Yuel | Amministratore | 1 Millbank EH14 7GA Balerno Midlothian | Scotland | British | Sales & Marketing Director | 311670004 | ||||
MILNE, Melissa | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | Scotland | British | Financial Controller | 309104820001 | ||||
MURRAY, Robert | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | Scotland | British | Director | 243337100001 | ||||
MURRAY, Suzanne | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | Scotland | British | Director | 309104810001 | ||||
WILSON, Donna | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | Scotland | British | Chief Operating Officer | 312378400001 | ||||
LYLE, Janet Horn Ewing | Segretario | Moor Edge Humbie Road Newton Mearns G77 5DF Glasgow | British | 541020001 | ||||||
DODDS, Stuart Douglas | Amministratore | Deepdene Park Road RH5 4AL Dorking Barkby Surrey | England | British | Director | 127346710002 | ||||
HOUSTON, James Baxter | Amministratore | 4 Eagle Terrace Sorrento Road IRISH Dalkey Dublin Ireland | United Kingdom | British | Technical Director | 79741390001 | ||||
HOUSTON, James Baxter | Amministratore | 3 Seyton Court Giffnock G46 6QA Glasgow Scotland | British | Designer | 19241420001 | |||||
JONES, Christopher Michael | Amministratore | Law Place Nerston Mains Industrial Estate G74 4QQ East Kilbride 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 194535180001 | ||||
LLOYD, Sean Peter | Amministratore | Law Place Nerston Mains Industrial Estate G74 4QQ East Kilbride 1 | England | British | Director | 197898870001 | ||||
LYLE, Iain Bruce | Amministratore | Flat G/R 10 Riverview Place The Water Front G5 8EH Glasgow | British | Commercial Director | 55584690001 | |||||
LYLE, Iain Bruce Methven | Amministratore | Moor Edge Humbie Road Newton Mearns G77 5DF Glasgow Lanarkshire | British | Managing Director | 19214710001 | |||||
LYLE, Janet Horn Ewing | Amministratore | Moor Edge Humbie Road Newton Mearns G77 5DF Glasgow | British | Director | 541020001 | |||||
MCKNIGHT, James Walter Andrew | Amministratore | 452 Kilmarnock Road G43 2RL Glasgow Lanarkshire | British | Chartered Accountant | 67809040001 | |||||
PAGAN, Russell Keith | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | England | British | Director | 243337700001 | ||||
POOLE, Scott Kirkwood | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | Scotland | British | Company Director | 69718770002 | ||||
ROBERTS, Christopher | Amministratore | Abinger Drive RH1 6SY Redhill 60 Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 139703730001 | ||||
STRANG, Roderick | Amministratore | Bayhall Road TN2 4UG Tunbridge Wells 21 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 139703750001 | ||||
TAGGART, William | Amministratore | 1 Tukalo Court ML10 6UU Strathaven South Lanarkshire | United Kingdom | British | Contracts Director | 84062490001 | ||||
THEODOROU, Athanasios | Amministratore | Young Place East Kilbride G75 0TD Glasgow 2 Scotland | England | Greek | Company Director | 290561220001 | ||||
THOMPSON, Barry | Amministratore | 5 Lucas Road Tockwith YO5 8QY York North Yorkshire | British | Sales / Marketing | 29512670001 | |||||
THYNE, Graham | Amministratore | 2 Elphinstone Crescent East Kilbride G75 0PN Glasgow | British | Sales Director | 33616470001 | |||||
TUCK, Graham Joseph | Amministratore | Glenside Lodge Culzean KA19 8JJ Maybole Ayrshire | British | Traffic Division Manager | 73741940002 | |||||
WALLACE, Gary David | Amministratore | 5 Lednock Road Stepps G33 6LJ Glasgow | Scotland | British | Accountant | 55569960001 | ||||
WITHERS, David | Amministratore | Witsend Inkpen Common RG15 0QP Newbury Berks | British | Sales & Marketing Director | 17068290001 | |||||
WRIGHT, Daniel Whitelaw, Professor | Amministratore | Blair Mill KA24 4EY Dalry Ayrshire Scotland | United Kingdom | British | Consulting Engineer & Co Dir | 4974690001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MERSON SIGNS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Roderick Ian Arthur Angus | 06 apr 2016 | Law Place Nerston Mains Industrial Estate G74 4QQ East Kilbride 1 | Sì | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: Scotland | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Dio Limited | 06 apr 2016 | Law Place East Kilbride G74 4QQ Glasgow 1 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MERSON SIGNS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 15 ott 2020 Consegnato il 19 ott 2020 | In corso | ||
Breve descrizione All and whole the subjects comprising 2 young place, east kilbride, glasgow G75 0TD being 3.25 hectares in measurement on the ordnance map registered in the land register of scotland under title number LAN128908. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 02 ott 2020 Consegnato il 08 ott 2020 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
A registered charge | Creato il 25 ott 2019 Consegnato il 31 ott 2019 | In corso | ||
Breve descrizione N/A. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
A registered charge | Creato il 05 apr 2016 Consegnato il 06 apr 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione A legal assignment of contract monies. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 27 lug 2015 Consegnato il 12 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
A registered charge | Creato il 27 lug 2015 Consegnato il 30 lug 2015 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
A registered charge | Creato il 27 lug 2015 Consegnato il 28 lug 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 1 bentalls, basildon SS14 3BS. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 08 lug 2015 Consegnato il 14 lug 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the subjects known as 2 young place, east kilbride, glasgow, G75 0TD registered in the land register of scotland under title number LAN128908. Contiene un'ipotesi negativa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 18 dic 2012 Consegnato il 22 dic 2012 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Floating charge | Creato il 13 mag 2011 Consegnato il 19 mag 2011 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 20 gen 2005 Consegnato il 09 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 08 giu 1998 Consegnato il 15 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1 law place,nerston mains,east kilbride. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 19 mag 1998 Consegnato il 01 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Standard security | Creato il 18 ago 1986 Consegnato il 01 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land together with factory premises known as one law place, nerston, east kilbride. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 18 ago 1986 Consegnato il 22 ago 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 0.940 acres with factory building, 1 law place, east kilbride. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 09 ago 1977 Consegnato il 12 ago 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1 law place, newton industrial estate, east kilbride (clyde). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 25 giu 1975 Consegnato il 04 lug 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £62,865 & all further moneys due, or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Lease of plot of ground extending to nine hundred & forty one thousandth parts of an acre at 1 law pl. Nerston industrial estate E. kilbride. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 29 feb 1972 Consegnato il 03 mar 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0