THE TWEEDDALE PRESS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE TWEEDDALE PRESS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC020984 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
- Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione
Dove si trova THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Passaggio dall'amministrazione allo scioglimento | 33 pagine | AM23(Scot) | ||||||||||
Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore | 33 pagine | AM10(Scot) | ||||||||||
Avviso di proroga del periodo di amministrazione | 5 pagine | AM19(Scot) | ||||||||||
Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore | 35 pagine | AM10(Scot) | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Guy Butterworth come amministratore in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Michael Mccall come segretario in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John King come amministratore in data 17 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Proposta presunta dell'amministratore | 1 pagine | 2.16BZ(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8th Floor Orchard Brae House, 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS a 272 Bath Street Glasgow G2 4JR in data 06 dic 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Stato patrimoniale con modulo allegato 2.13B(Scot) | 4 pagine | 2.15B(Scot) | ||||||||||
Proposta dell'amministratore | 111 pagine | 2.16B(Scot) | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 2 pagine | 2.11B(Scot) | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2017 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Guy Butterworth come amministratore in data 24 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashley Gilroy Mark Highfield come amministratore in data 05 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 108 Holyrood Road Edinburgh EH8 8AS Scotland a 8th Floor Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 108 Holyrood Road Edinburgh EH8 8AS | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 02 gen 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Alan Stephen Plews come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Stephen Plews come amministratore in data 01 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDGEON, Edward | Segretario | 25 Cottage Road NE71 6AD Wooler Northumberland | British | 19728160001 | ||||||
| MCCALL, Peter Michael | Segretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 | 161445620001 | |||||||
| SIMMONS, John Edward | Segretario | 4 Valley View Tweedmouth TD15 2ED Berwick Upon Tweed | British | 37365190002 | ||||||
| SMAIL, John Daniel Richardson | Segretario | Lindean Farmhouse Lindean TD7 4QW Selkirk Borders | British | 41960002 | ||||||
| SPEIGHT, Arthur John Peter | Segretario | 37 High Street NE71 6BU Wooler Northumberland | British | 41920001 | ||||||
| ANDREW, James Houston | Amministratore | Fogo Mains Fogo TD11 3RA Duns Berwickshire | United Kingdom | British | 62235680001 | |||||
| ARMSTRONG, Anthony Bowes | Amministratore | Riverview Cottage Lilliesleaf TD6 9JB Melrose Roxburghshire | British | 35246880001 | ||||||
| BIRKETT, Stuart James | Amministratore | 10 Eildon View TD15 2FQ Berwick Upon Tweed Northumberland | United Kingdom | British | 174124340001 | |||||
| BOWDLER, Timothy John | Amministratore | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | 37521870002 | |||||
| BROTHERSTON, Richard | Amministratore | 8 Strathearn Road EH9 2AE Edinburgh Midlothian | British | 39940001 | ||||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 | England | British | 76600500002 | |||||
| CASKIE, David Baird | Amministratore | 88 Maggiewoods Loan FK1 5EH Falkirk | Scotland | British | 45898950001 | |||||
| CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Amministratore | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | Scotland | British | 474360001 | |||||
| DOWNIE, George Waddell | Amministratore | The Gables,Close Farm Hatch Beauchamp TA3 6AE Taunton Somerset | British | 26306280002 | ||||||
| DUDGEON, Edward | Amministratore | 25 Cottage Road NE71 6AD Wooler Northumberland | British | 19728160001 | ||||||
| FRY, John Anthony | Amministratore | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | 136914890001 | |||||
| HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 164400440001 | |||||
| KING, David John | Amministratore | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 | United Kingdom | British | 179020430001 | |||||
| MCINTYRE, Keith William | Amministratore | 49 Meldrum Mains Glenmavis ML6 0QQ Airdrie Lanarkshire | Scotland | British | 112687860001 | |||||
| MCPHERSON, Stuart | Amministratore | 8 Heriot Road Lenzie G66 5AY Glasgow | Scotland | British | 986760004 | |||||
| MURRAY, Grant | Amministratore | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | 159877110001 | |||||
| PATERSON, Stuart Randall | Amministratore | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 64281400001 | |||||
| PLEWS, Alan Stephen | Amministratore | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor | England | British | 27819010002 | |||||
| RICHARDSON, John Daniel | Amministratore | Lindean Farmhouse Lindean TD7 4QW Selkirk | British | 47707970001 | ||||||
| SMAIL, Derek James Richardson | Amministratore | Waimate East Ord TD15 2NS Berwick Upon Tweed Northumberland | England | British | 41950001 | |||||
| SMAIL, Dorothy Margaret | Amministratore | Kiwi Cottage Scremerston TD15 2RB Berwick Upon Tweed Northumberland | British | 41940001 | ||||||
| SMAIL, James Ingram Miles | Amministratore | Kiwi Cottage Scremerston TD15 2RB Berwick Upon Tweed Northumberland | British | 41930001 | ||||||
| SMAIL, John Daniel Richardson | Amministratore | Lindean Farmhouse Lindean TD7 4QW Selkirk Borders | British | 41960002 | ||||||
| WALLACE, David Forster | Amministratore | The Whins Unthbank Square TD15 2NG Berwick-Upon-Tweed Northumberland | British | 65583180002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnston Publishing Limited | 06 apr 2016 | Bourges Boulevard PE1 1NG Peterborough Unex House - Suite B Cambridgeshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 giu 2014 Consegnato il 04 lug 2014 | In corso | ||
Breve descrizione All material real property owned by the chargor on the date of the security agreement see form for further details. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| A registered charge | Creato il 16 giu 2014 Consegnato il 24 giu 2014 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Deed of accession | Creato il 25 set 2009 Consegnato il 06 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Standard security | Creato il 04 mar 1991 Consegnato il 11 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The hermitage selkirk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 12 set 1986 Consegnato il 24 set 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £27375 and all further sums due or to become due | |
Brevi particolari 13 thomson gate tweedmonte. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 28 ago 1979 Consegnato il 30 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Shop and dwellinghouse forming numbers 1 & 3 easter street, dums in the town and parish of dums in the county of berwick. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 ago 1979 Consegnato il 21 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects in boarding school yard, berwick upon tweed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 ago 1979 Consegnato il 21 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 94/94A marygate, berwick upon tweed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 15 ago 1979 Consegnato il 21 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Kuri cottages, scremerston, berwick upon tweed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 mag 1979 Consegnato il 25 mag 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 51 high street selkirk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 mag 1979 Consegnato il 25 mag 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 53 high street, selkirk. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 mag 1979 Consegnato il 25 mag 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 19 bridge street, kelso, roxburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 mag 1979 Consegnato il 25 mag 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Northmost shop at 33 high street, jedburgh. County of roxburgh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 29 gen 1979 Consegnato il 02 feb 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 dic 1976 Consegnato il 07 dic 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Freehold property "weimate", east old berwick upon tweed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| G r s roxburgh standard security | Creato il 05 mar 1976 Consegnato il 08 mar 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land & store at 8 buccleuch st., Hawick. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0