GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED

GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC025083
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BETT (DP) LIMITED07 set 199907 set 1999
    DICK PRECAST LIMITED16 giu 198816 giu 1988
    CHARLES DICK & SON, LIMITED25 feb 194725 feb 1947

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    legacy

    3 pagineMG02s

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Stato del capitale al 12 gen 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ in data 02 feb 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Johnson come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Joanne Elizabeth Massey come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del segretario cambiati per Robin Simon Johnson il 24 nov 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 13 nov 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809200001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Amministratore
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Amministratore
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    BETT, Stewart
    4 Pitempton Road
    Downfield
    DD3 9EJ Dundee
    Angus
    Amministratore
    4 Pitempton Road
    Downfield
    DD3 9EJ Dundee
    Angus
    British175330001
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Amministratore
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    ELLIS, Gordon William
    77 Carlogie Road
    DD7 6EX Carnoustie
    Angus
    Amministratore
    77 Carlogie Road
    DD7 6EX Carnoustie
    Angus
    British319190001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Amministratore
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Amministratore
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001
    SAUNDERS, Gordon Scott
    4 Kippford Street
    Monifieth
    DD5 4TT Dundee
    Amministratore
    4 Kippford Street
    Monifieth
    DD5 4TT Dundee
    British39891340001
    TOWNSEND, Ian Trye
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    Amministratore
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    United KingdomBritish320150001

    GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Letter of offset
    Creato il 10 apr 1984
    Consegnato il 24 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by bett brothers & or others to the chargee
    Brevi particolari
    The balance at credit of any accounts held by bank of scotland in name of charles dick & son LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Letter of offset
    Creato il 13 ott 1980
    Consegnato il 17 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by bett brothers (arbroath) LTD and/or another
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of charles dick & son limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Letter of offset
    Creato il 14 nov 1978
    Consegnato il 20 nov 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of charles dick & son LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 nov 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0