ABERLOUR HOUSE LIMITED

ABERLOUR HOUSE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABERLOUR HOUSE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società SC025720
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gordonstoun School
    Elgin
    IV30 5RF Morayshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Bryan Peter Williams come amministratore in data 03 ott 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Professor Bryan Peter Williams come amministratore in data 03 ott 2020

    2 pagineAP01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Hugh Spence Brown come segretario in data 16 mag 2018

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Bryan Peter Williams come amministratore in data 01 giu 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Yeoman come amministratore in data 01 giu 2018

    1 pagineTM01

    Ordinanza giudiziaria

    Order of court - dissolution void
    1 pagineOC-DV

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ago 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ago 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ago 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2010, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Bryan Peter Williams il 01 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Yeoman il 01 mar 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 ago 2008

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARR, George Jefferson
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    Segretario
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    British38294790001
    BROWN, Hugh Spence
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    Segretario
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    British40872570003
    BROWN, James Ogg, Commander
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    Segretario
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    British37334700001
    SPENCER, John Robert, Squadron Leader
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    Segretario
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    British50650460002
    WHITTLE, Colin Douglas Richardson
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Segretario
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    British536270001
    BUCHANAN, Ewan Craig Barr
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    Amministratore
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    United KingdomBritish404330003
    CAUNT, Christine Janet
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    British5133580001
    DICKINSON, John Joicey
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    Amministratore
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    British1278160001
    DONALD, Charles
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    EnglandBritish69189660001
    DRUMMOND, Norman
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    British68147030002
    FARQUHARSON, Clodagh
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    Amministratore
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    British7047470001
    FERGUSON, James Gordon Dickson
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish23960001
    FOGDEN, Andrew Mark
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    British74942750002
    GORDON DUFF, Priscilla Margaret
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    Amministratore
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    KeithBritish47184790001
    GRUNEBAUM, George Peter
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    Amministratore
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    United StatesAmerican96073500001
    HILL, Caroline Elizabeth
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    Amministratore
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    British1054220001
    HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish69284900001
    HUNT, Flora Christine Campbell
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    British1323300001
    INGLEBY, Moira Frances
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    British45709310001
    ISMAY CHEAPE, Emma Margaret
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    Amministratore
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    British38383690001
    JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    Amministratore
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    ScotlandBritish1390490001
    LOCKE, Alasdair James Dougall
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    Amministratore
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    United KingdomBritish115457770001
    LUMLEY, Tessa Jocelyn
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    Amministratore
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    British85182640001
    MACDONALD, Angus Stewart
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    Amministratore
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    British1220020001
    MARTIN, Hector John Bruce
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    Amministratore
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    British54403370002
    MATHEWSON, George
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    Amministratore
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    British1054210001
    MITCALFE, Alan Hugh
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    Amministratore
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    British8870980001
    MORGAN, Angus
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    Amministratore
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    British1142050001
    NASH, Mark Andrew
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    Amministratore
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    ScotlandBritish114921310001
    NICHOLSON, John Richard
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    Amministratore
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    United KingdomBritish1054200007
    NICHOLSON, John Richard
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    Amministratore
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    British1054200001
    OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    British45709230001
    ORD, Peter John
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish948580002
    RUANE, Richard James
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    Amministratore
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    British1293210002
    SABBAN-CLARKE, James Paley
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    Amministratore
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    British89104030001

    ABERLOUR HOUSE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 30 apr 2002
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 05 nov 1990
    Consegnato il 19 nov 1990
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 nov 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    Floating charge
    Creato il 01 ago 1983
    Consegnato il 03 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 & all further sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transazioni
    • 03 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 25 lug 1983
    Consegnato il 29 lug 1983
    In corso
    Importo garantito
    £75,000,00
    Brevi particolari
    All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others.
    Persone aventi diritto
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transazioni
    • 29 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Disposition
    Creato il 29 set 1969
    Consegnato il 02 mar 1970
    In corso
    Importo garantito
    £4,000
    Brevi particolari
    New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Building Society
    Transazioni
    • 02 mar 1970Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0