ABERLOUR HOUSE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ABERLOUR HOUSE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
| Numero di società | SC025720 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ABERLOUR HOUSE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Gordonstoun School Elgin IV30 5RF Morayshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Cessazione della carica di Bryan Peter Williams come amministratore in data 03 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Professor Bryan Peter Williams come amministratore in data 03 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Cessazione della carica di Hugh Spence Brown come segretario in data 16 mag 2018 | 2 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Bryan Peter Williams come amministratore in data 01 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di John Yeoman come amministratore in data 01 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Ordinanza giudiziaria Order of court - dissolution void | 1 pagine | OC-DV | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2012 | 7 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 19 feb 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 4 pagine | AR01 | ||
Bilancio redatto al 31 ago 2011 | 10 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 19 feb 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 4 pagine | AR01 | ||
Bilancio redatto al 31 ago 2010 | 10 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 19 feb 2011, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 4 pagine | AR01 | ||
Bilancio redatto al 31 ago 2009 | 8 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 19 feb 2010, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 3 pagine | AR01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bryan Peter Williams il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Yeoman il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 ago 2008 | 10 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARR, George Jefferson | Segretario | Gordonstoun School IV30 2RF Elgin Moray | British | 38294790001 | ||||||
| BROWN, Hugh Spence | Segretario | 13 Beech Brae IV30 4NS Elgin Moray | British | 40872570003 | ||||||
| BROWN, James Ogg, Commander | Segretario | The White House Duffus IV30 2QN Elgin Morayshire | British | 37334700001 | ||||||
| SPENCER, John Robert, Squadron Leader | Segretario | Kilcluan House IV30 8LA Elgin Morayshire | British | 50650460002 | ||||||
| WHITTLE, Colin Douglas Richardson | Segretario | 121 High Street IV36 1AB Forres | British | 536270001 | ||||||
| BUCHANAN, Ewan Craig Barr | Amministratore | Mayne House IV30 3RS Elgin Morayshire | United Kingdom | British | 404330003 | |||||
| CAUNT, Christine Janet | Amministratore | 43 Park Town OX2 6SL Oxford Oxfordshire | British | 5133580001 | ||||||
| DICKINSON, John Joicey | Amministratore | Dipple House IV32 7QA Fochabers Moray | British | 1278160001 | ||||||
| DONALD, Charles | Amministratore | Plow Green Hartley Wespall RG27 0AL Hook Hampshire | England | British | 69189660001 | |||||
| DRUMMOND, Norman | Amministratore | 24 Huntingdon Place EH7 4AX Edinburgh Midlothian | British | 68147030002 | ||||||
| FARQUHARSON, Clodagh | Amministratore | Dallas Lodge IV36 0RY Forres Moray | British | 7047470001 | ||||||
| FERGUSON, James Gordon Dickson | Amministratore | 25 Heriot Row EH3 6EN Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 23960001 | |||||
| FOGDEN, Andrew Mark | Amministratore | Wardsley Farmhouse Leagram Chipping PR3 2QT Preston Lancashire | British | 74942750002 | ||||||
| GORDON DUFF, Priscilla Margaret | Amministratore | Kirkton House Drummuir AB55 3JE Keith Banffshire | Keith | British | 47184790001 | |||||
| GRUNEBAUM, George Peter | Amministratore | 352 Mclain Street Bedford Hills New York 10507 Usa | United States | American | 96073500001 | |||||
| HILL, Caroline Elizabeth | Amministratore | Taylors Wynd Clocksbriggs DD8 2TA Forfar Angus | British | 1054220001 | ||||||
| HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne | Amministratore | Gatcombe Park Hampton Fields, Minchinhampton GL6 9AT Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 69284900001 | |||||
| HUNT, Flora Christine Campbell | Amministratore | 39 Stratherrick Road IV2 4LF Inverness Inverness Shire | British | 1323300001 | ||||||
| INGLEBY, Moira Frances | Amministratore | Invermarkie Glass AB54 4XY Huntly Aberdeenshire | British | 45709310001 | ||||||
| ISMAY CHEAPE, Emma Margaret | Amministratore | Middleton Fossoway KY13 6PB Kinross | British | 38383690001 | ||||||
| JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel | Amministratore | Spynie Kirk House Spynie IV30 8XJ Elgin Moray | Scotland | British | 1390490001 | |||||
| LOCKE, Alasdair James Dougall | Amministratore | Glenrinnes Lodge Dufftown AB55 4BS Keith Banffshire Scotland | United Kingdom | British | 115457770001 | |||||
| LUMLEY, Tessa Jocelyn | Amministratore | Flat 4 10 Westbourne Gardens W2 5PU London | British | 85182640001 | ||||||
| MACDONALD, Angus Stewart | Amministratore | Torgorm Conon Bridge IV7 8DN Dingwall Ross & Cromarty | British | 1220020001 | ||||||
| MARTIN, Hector John Bruce | Amministratore | Windmill Cottage 38 High Street AB38 9QD Aberlour Banffshire | British | 54403370002 | ||||||
| MATHEWSON, George | Amministratore | Netherfield Skye Of Kurr PH26 3PA Dulnain Bridge Grantown On Spey Moray | British | 1054210001 | ||||||
| MITCALFE, Alan Hugh | Amministratore | Milton Brodie IV36 0UA Forres Morayshire | British | 8870980001 | ||||||
| MORGAN, Angus | Amministratore | Mount Devon House FK14 7PT Dollar | British | 1142050001 | ||||||
| NASH, Mark Andrew | Amministratore | 54 Harbour Street IV30 5RU Hopeman Moray | Scotland | British | 114921310001 | |||||
| NICHOLSON, John Richard | Amministratore | Romach House Dunphail IV36 2QR Forres Morayshire | United Kingdom | British | 1054200007 | |||||
| NICHOLSON, John Richard | Amministratore | Mayne Lodge Mayne IV30 3SX Elgin Moray | British | 1054200001 | ||||||
| OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle | Amministratore | Netherdale House AB53 7LE Turriff Aberdeenshire | British | 45709230001 | ||||||
| ORD, Peter John | Amministratore | Baile Na Coille Balmoral AB35 5TB Ballater Aberdeenshire | Scotland | British | 948580002 | |||||
| RUANE, Richard James | Amministratore | Willow Vale Tradespark Road IV12 5NF Nairn Nairnshire | British | 1293210002 | ||||||
| SABBAN-CLARKE, James Paley | Amministratore | Sandy Hill Farm Corfe Castle BH20 5JF Wareham Dorset | British | 89104030001 |
ABERLOUR HOUSE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 30 apr 2002 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 05 nov 1990 Consegnato il 19 nov 1990 | In corso | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 01 ago 1983 Consegnato il 03 ago 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £75,000 & all further sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 25 lug 1983 Consegnato il 29 lug 1983 | In corso | Importo garantito £75,000,00 | |
Brevi particolari All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Disposition | Creato il 29 set 1969 Consegnato il 02 mar 1970 | In corso | Importo garantito £4,000 | |
Brevi particolari New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0