HAMISH MORISON LIMITED

HAMISH MORISON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAMISH MORISON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC027749
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HAMISH MORISON LIMITED?

    • (0122) /

    Dove si trova HAMISH MORISON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAMISH MORISON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per HAMISH MORISON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Dettagli del segretario cambiati per Tmf Corporate Administration Services Limited il 19 set 2011

    2 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ in data 27 mag 2011

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 mag 2011

    LRESSP

    Nomina di Mark Steven come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2011

    Stato del capitale al 15 apr 2011

    • Capitale: GBP 314,027
    SH01

    Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Mawlaw Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter John Miller il 14 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Antonius Lammers come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Ronald William Francis il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Antonius Matheus Maria Lammers il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Nomina di Mr Louis Antoine Maria Vernaus come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 22 nov 2008

    17 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sect 175(5)(a) CA2006 19/02/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di HAMISH MORISON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritish105961550001
    MILLER, Peter John
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritish55542610002
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    KERR, David John Macfarlane
    2 Thorn Street
    TD4 6DR Earlston
    Berwickshire
    Segretario
    2 Thorn Street
    TD4 6DR Earlston
    Berwickshire
    British337760001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    CRAWFORD, Thomas Johnstone
    25 Upper Loan Park
    TD2 6TR Lauder
    Berwickshire
    Amministratore
    25 Upper Loan Park
    TD2 6TR Lauder
    Berwickshire
    British337790001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    HOPLEY, Philip Thomas
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    Amministratore
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    British957150007
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    KERR, David John Macfarlane
    2 Thorn Street
    TD4 6DR Earlston
    Berwickshire
    Amministratore
    2 Thorn Street
    TD4 6DR Earlston
    Berwickshire
    British337760001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Amministratore
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Dutch126350570004
    LEWINS, Andrew Jon
    Challows 14 Woodland Drive
    Thorpe End
    NR13 5BH Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Challows 14 Woodland Drive
    Thorpe End
    NR13 5BH Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish43542320002
    MACCALLUM, Alasdair Norman
    Inverossie
    Rossie Braes
    DD10 9TJ Montrose
    Angus
    Amministratore
    Inverossie
    Rossie Braes
    DD10 9TJ Montrose
    Angus
    ScotlandBritish465170001
    MELDRUM, Allan Charles Clark
    Leaderdale Crescent
    TD4 6BJ Earlston
    5
    Scottish Borders
    Amministratore
    Leaderdale Crescent
    TD4 6BJ Earlston
    5
    Scottish Borders
    ScotlandBritish131775070001
    MORISON, Grace
    West Morriston
    TD4 6AY Earlston
    Berwickshire
    Amministratore
    West Morriston
    TD4 6AY Earlston
    Berwickshire
    ScotlandBritish337780002
    MORISON, James Douglas
    West Morriston
    TD4 6AZ Earlston
    Berwickshire
    Amministratore
    West Morriston
    TD4 6AZ Earlston
    Berwickshire
    ScotlandBritish66098800002
    MORISON, James Douglas Rutherford
    West Morriston
    TD4 6AY Earlston
    Berwickshire
    Amministratore
    West Morriston
    TD4 6AY Earlston
    Berwickshire
    ScotlandBritish337770001
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    POLLOCK, Timothy Anthony Hugo
    Scholars House
    Longwitton
    NE61 4JZ Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Scholars House
    Longwitton
    NE61 4JZ Morpeth
    Northumberland
    British41902480001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001

    HAMISH MORISON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 28 mag 1999
    Consegnato il 15 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Various properties-see ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
    Transazioni
    • 15 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 feb 1999
    Consegnato il 10 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Crosshall, greenlaw--hareburn, stirling and others (see ch microfiche).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 set 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 29 gen 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 giu 1999Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 mar 2001Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 29 gen 1999
    Consegnato il 17 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 giu 1999Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 mar 2001Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 23 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    6.77 acres, part of the farm and lands of edingham,county of stewartry,kirkcudbright.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.216 acres and 0.397 acres of the farm and lands of greenknowe,county of berwick.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.50 ha of the lands of west morriston,county of berwick.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.836 hectares,part of the lands of crosshall,county berwick.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 set 1998
    Consegnato il 07 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.527 acres & 4.071 acres in the barony of greenlaw redpath,county of berwwick.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 01 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The hatchery, grove lane, stanton, suffolk, registered under title number sk 12914.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 01 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The hatchery, grove lane, stanton, suffolk, registered under title number sk 12914.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 dic 1992
    Consegnato il 15 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Broiler unit orange lane leitholm berwickshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 01 dic 1992
    Consegnato il 16 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Manor farm, wyton, near hull.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal cherge
    Creato il 01 dic 1992
    Consegnato il 16 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Mytholmroyd hatchery, hall bank lane, mytholmroyd.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 ott 1992
    Consegnato il 19 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Poultry unit, station road, duns.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 27 dic 1990
    Consegnato il 31 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Quarry farm, sandy lane, farnham knaresborough north yorkshire nyk 87485.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    6.80 acres known as sand hall farm winterton mill poultry sheds.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    11.2 acres with poultry houses and barns part of forest farm holme on spalding moor humberside.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land north side of holmes lane winterton humberside title no hs 75271.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2 holmes lane winterton humberside.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2 robinson bungalows leys lane farm winterton humberside.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    32 old lea road holme on spolding moor humberside HS130185.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 gen 1990
    Consegnato il 23 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Victoria hatchery victoria road diss norfolk.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    HAMISH MORISON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 apr 2012Data di scioglimento
    11 mag 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0