A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED

A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàA. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC029680
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED?

    • (5231) /

    Dove si trova A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Robert Owen House
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 27 feb 2014

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Alan Harrison come amministratore

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagineAC93

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 21 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2011

    Stato del capitale al 05 mag 2011

    • Capitale: GBP 5,500
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Alan John Harrison il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 02 gen 2010

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Alan John Harrison il 21 mar 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Peter Batty come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Katherine Eldridge come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio redatto al 10 gen 2009

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di Jonathan Brocklehurst come amministratore

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 11 gen 2010 al 04 gen 2010

    1 pagineAA01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Robert Owen House
    Segretario
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Robert Owen House
    150340080001
    NUTTALL, John Branson
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish137558680001
    COOK, Margaret Kerr
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    Segretario
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    British436100003
    COOK, Philippa Betty
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Segretario
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Australian84440150003
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    COOK, Margaret Kerr
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    British436100003
    COOK, Peter James Henderson
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Amministratore
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    British809330007
    COOK, Philippa Betty
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Amministratore
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Australian84440150003
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Amministratore
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    HARRISON, Alan John
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    ScotlandBritish97831730001
    KENT, Ronald
    5 Christie Street
    KY12 0AQ Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    5 Christie Street
    KY12 0AQ Dunfermline
    Fife
    British436110001
    NOBLE, Spencer John
    23 Hallowes Drive
    S18 1YH Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    23 Hallowes Drive
    S18 1YH Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish115498920001

    A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of goodwill
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 27 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The goodwill, custom and connection of the company in relation to the pharmacy business carried on by the company - see form 410 for more details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 15 mag 2006
    Consegnato il 20 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Aah Pharmaceuticals LTD and Another
    Transazioni
    • 20 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of goodwill
    Creato il 10 feb 2006
    Consegnato il 20 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The goodwill, custom and connection of the company in relation to the pharmacy business carried on by the company at 64 bank street, lochgelly together with the exclusive right for the bank to carry on the said pharmacy business under the name of 'A. robertson & son (chemists) limited', or such other name or names as may be approved by the bank in writing and the benefit of all rights and privileges accruing thereto and remedies for enforcing the same and respectively to represent the bank as carrying on the said pharmacy business in succession t o the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation of goodwill
    Creato il 10 feb 2006
    Consegnato il 20 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The goodwill, custom and connection of the company in relation to the pharmacy business carried on by the company at elliot street, dunfermline together with the exclusive right for the bank to carry on the said pharmacy business under the name of 'A. robertson & son (chemists) limited', or such other name or names as may be approved by the bank in writing and the benefit of all rights and privileges accruing thereto and remedies for enforcing the same and respectively to represent the bank as carrying on the said pharmacy business in succession to the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 21 apr 2005
    Consegnato il 29 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    18 douglas street, dunfermline, fife ffe 3636.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 19 nov 2004
    Consegnato il 26 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 dic 2006Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 04 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 09 set 1995
    Consegnato il 29 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £105,000
    Brevi particolari
    18/20 douglas street, dunfermline, fife.
    Persone aventi diritto
    • Mrs Margaret Kerr Cook
    Transazioni
    • 29 set 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 ott 1989
    Consegnato il 01 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0