VION SUBCO MD LIMITED

VION SUBCO MD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVION SUBCO MD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC030556
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VION SUBCO MD LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova VION SUBCO MD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VION SUBCO MD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MCINTOSH DONALD LIMITED06 mar 198906 mar 1989
    WILLIAM DONALD & SON (WHOLESALE MEAT CONTRACTORS) LIMITED31 gen 195531 gen 1955

    Quali sono gli ultimi bilanci di VION SUBCO MD LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2014
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2015
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per VION SUBCO MD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    9 pagine4.26(Scot)

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA a C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 23 apr 2015

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 apr 2015

    LRESSP

    Stato del capitale al 24 feb 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced 23/02/2015
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2014

    Stato del capitale al 04 nov 2014

    • Capitale: GBP 1,978,570
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    6 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* in data 12 dic 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2013

    Stato del capitale al 09 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,978,570
    SH01

    Cessazione della carica di Jose Peralta come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Leon Barry Abbitt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Steven come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Louis Vernaus come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maarten Kusters come amministratore

    1 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed mcintosh donald LIMITED\certificate issued on 04/04/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 apr 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 03 apr 2013

    RES15
    change-of-name04 apr 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    legacy

    12 pagineMG01s

    legacy

    9 pagineMG01s

    Chi sono gli amministratori di VION SUBCO MD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish153119640001
    BUCHAN, Ian
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British388530001
    NAPIER, Keith Graham
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British138570001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BUCHAN, Eric
    Glenisla
    Grampian Terrace, Torphins
    AB31 4JS Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Glenisla
    Grampian Terrace, Torphins
    AB31 4JS Banchory
    Kincardineshire
    British91024360001
    BUCHAN, Ian
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British388530001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    DUNCAN, Gordon Scott
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    British33741760001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritish105961550001
    GREEN, Ralph
    37 Rutherford Folds
    AB51 4JH Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    37 Rutherford Folds
    AB51 4JH Inverurie
    Aberdeenshire
    British56693150001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutch167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Amministratore
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Dutch126350570004
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish515220001
    MCNAUGHTON, Alan John
    Ashlade
    Waulkmill Farm
    AB30 1EJ Laurencekirk
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Ashlade
    Waulkmill Farm
    AB30 1EJ Laurencekirk
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish44916150002
    MELVIN, John Robertson
    18 Moray Place
    AB15 4AG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    18 Moray Place
    AB15 4AG Aberdeen
    Aberdeenshire
    British134100002
    NAPIER, Keith Graham
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British138570001
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PERALTA, Jose
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    WalesSpanish55989090003
    POCOCK, Patrick William
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    Amministratore
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    British36234170001
    PROVAN, James Lyal Clark
    Wallacetown
    Bridge Of Earn
    PH2 8QA Perth
    Amministratore
    Wallacetown
    Bridge Of Earn
    PH2 8QA Perth
    British1041290001
    RHIND, Evelyn Kerr
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British389060001
    RHIND, John
    Dearg Sheiling
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Dearg Sheiling
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British389050001
    ROEBUCK, Robert Isla
    Balquharn Farmhouse
    Badentoy Road
    Portlethen
    Aberdeen
    Amministratore
    Balquharn Farmhouse
    Badentoy Road
    Portlethen
    Aberdeen
    British56693510004
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SOBEY, Michael John
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    Amministratore
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    United KingdomBritish895550001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    STEPHEN, Eric John
    Rosebank, Mainstreet
    Rothienorman
    AB51 8UD Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Rosebank, Mainstreet
    Rothienorman
    AB51 8UD Inverurie
    Aberdeenshire
    British441180002
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    STRACHAN, Wilfred
    Denview
    Kingswells
    AB1 8PT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Denview
    Kingswells
    AB1 8PT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British388540001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001

    VION SUBCO MD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking security agreement
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 12 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 15 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First ranking security agreement
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 12 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 15 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 24 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 21 set 1998
    Consegnato il 06 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The meat factory and others,portlethen,kincardineshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 06 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 ago 1998Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 giu 2007Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 15 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 10 set 1996
    Consegnato il 20 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The meat factory,portlethen and other properties...............see ch paper apart 2 on ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 set 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 01 set 1995
    Consegnato il 19 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The meat factory, portlethen and other properties........ See ch microfiche.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 19 set 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 mar 1995
    Consegnato il 11 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    See page 2 of doc.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 17 mar 1995
    Consegnato il 28 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee of Others
    Transazioni
    • 28 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 18 ago 1993
    Consegnato il 27 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Obligations contained in missivesdated 23RD april, 5TH, 10TH (2 letters), 12TH, 24TH and 25TH all days of may 1993
    Brevi particolari
    (1ST) 3 strips of ground part of the farm and lands of milton of kemnay, kemnay, aberdeenshire as relative to disposition by mcintosh donald LTD ifo malcolm allan housebuilders LTD dated 30TH july and recorded grs aberdeen 18TH aug 1993. (2ND) 1,840 square metres part of the alford branch railway line in said parish described in disposition by grampian regional council ifo mcintosh donald LTD dated 26TH july and recorded grs aberdeen 4TH nov 1991.
    Persone aventi diritto
    • Malcolm Allan Housebuilders Limited
    Transazioni
    • 27 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 apr 1991
    Consegnato il 15 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The meat factory portlellen kincardinshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 11 mag 1988
    Consegnato il 24 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 25 giu 1980
    Consegnato il 03 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Farms and lands of damhead of minnes, foveran, aberdeenshire cockley, maryculter, kincardineshire milton of kemnay, kemnay, aberdeenshire hill of minnes, foveran, aberdeenshire mains of badentoy, portlethen, kincardineshire the farming unit of balquharn, cookston, eskywell and the lands of craighead, portlethen, kincardineshire extending in all to one thousand two hundred and seventy acres or thereby.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 03 lug 1980Registrazione di un'ipoteca

    VION SUBCO MD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 apr 2017Data prevista di scioglimento
    10 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0