WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED

WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC031250
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED?

    • (6110) /

    Dove si trova WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pkf
    78 Carlton Place
    G5 9TH Glasgow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARRISONS (CLYDE) LIMITED09 ago 200209 ago 2002
    HARRISONS (MANAGEMENT) LIMITED04 mag 200104 mag 2001
    STIRLING SHIPMANAGEMENT LIMITED 03 gen 199603 gen 1996
    HARRISONS (CLYDE) LIMITED04 gen 195604 gen 1956

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    3 pagine4.26(Scot)

    Avviso di riunione finale dei creditori

    2 pagine4.17(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    legacy

    1 pagine287

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed harrisons (clyde) LIMITED\certificate issued on 14/12/06
    2 pagineCERTNM

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2004

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2003

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2002

    16 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Bilancio redatto al 31 dic 2001

    14 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed harrisons (management) LIMITED\certificate issued on 09/08/02
    2 pagineCERTNM

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    British25620001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish25620001
    COWDEROY, James Anthony Frank
    303 Pendleton Lane
    33480 Palm Beach
    Florida
    United States Of America
    Amministratore
    303 Pendleton Lane
    33480 Palm Beach
    Florida
    United States Of America
    UsaBritish40380390002
    HARRISON, Patrick Charles Lorne
    Wester Rynabeallich
    Cromdale
    PH26 3LW Grantown On Spey
    Morayshire
    Amministratore
    Wester Rynabeallich
    Cromdale
    PH26 3LW Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritish37147780002
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish25620001
    BURROWS, Ian Edwin
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    British25670001
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Amministratore
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    DUNN, John Ward
    Ferniecraig
    PA17 5EH Skelmorlie
    Renfrewshire
    Amministratore
    Ferniecraig
    PA17 5EH Skelmorlie
    Renfrewshire
    British25660001
    FARLEY, Alastair Hugh
    Wardley Farm Upper Wardley Milland
    GU30 7LX Liphook
    Hampshire
    Amministratore
    Wardley Farm Upper Wardley Milland
    GU30 7LX Liphook
    Hampshire
    United KingdomBritish33275820003
    HARRISON, Iain Victor Robinson
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    Amministratore
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    ScotlandBritish38290001
    LAUCHLAN, William Briggs
    Elmgrove 16 Kilbride Avenue
    PA23 7LH Dunoon
    Argyll
    Amministratore
    Elmgrove 16 Kilbride Avenue
    PA23 7LH Dunoon
    Argyll
    British42773260001
    MACDONALD, Kenneth Malcolm
    13 Millfield Drive
    Hopeman
    IV30 5TN Moray
    Amministratore
    13 Millfield Drive
    Hopeman
    IV30 5TN Moray
    British40211890002
    MACDONALD, Kenneth Malcolm
    15 Roebank Road
    KA15 2DX Beith
    Ayrshire
    Amministratore
    15 Roebank Road
    KA15 2DX Beith
    Ayrshire
    British40211890001
    PATTEN, Thomas Diery
    67/7 Grange Loan
    EH9 2EG Edinburgh
    Amministratore
    67/7 Grange Loan
    EH9 2EG Edinburgh
    British3980960003
    WILSON, Andrew George
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    Amministratore
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    British782420001
    WORDIE, Peter Jeffrey
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    British25640001

    WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 08 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 08 gen 1996
    Consegnato il 22 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by stirling offshore limited
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 gen 1996Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 09 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Assignation in security
    Creato il 14 set 1995
    Consegnato il 05 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The company's right, title and interest in and to the "account" and the "balance"....... See ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • British Linen Leasing Limited
    Transazioni
    • 05 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of covenant
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement, guarantee and security documents
    Brevi particolari
    By way of security for the secured indebtedness the chargor as beneficial owner mortgages and charges and agrees to mortgage and charge to and in favour of the chargee all its rights, title and interest, present and future, to and in the ship and to and in the shares of the ship owned by the chargor.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Four party agreement
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement
    Brevi particolari
    1) the harrison's charterparty and the harrison's charter rights 2) all beneficial interest in any requisition compensation and the earnings............see ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Mortgage
    Creato il 21 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and to become due in terms of a guarantee, loan agreement and deed of covenant
    Brevi particolari
    13/64 shares, of which the chargor is owner, in the motor ship "stirling fyne" (ex edda fjord) registered on the bahamian flag at the port of nassau.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 27 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Office building 17 woodside crescent glasgow.
    Persone aventi diritto
    • John Swire & Sons Limited
    Transazioni
    • 27 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Shipping mortgage
    Creato il 13 nov 1989
    Consegnato il 24 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    M.V. stirling dee regd glasgow no 701091 & boats and appartements.
    Persone aventi diritto
    • John Swire & Sons Limited
    Transazioni
    • 24 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 13 nov 1989
    Consegnato il 23 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares in ship "burnhaven" 701005.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Mortgage
    Creato il 13 nov 1989
    Consegnato il 23 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64TH shares in ship "sandhaven" 701027.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of covenant
    Creato il 10 nov 1989
    Consegnato il 24 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All right, title and interest of the company present and future in 64/64TH shares of M.V. stirling dee see page 2 of document.
    Persone aventi diritto
    • John Swire & Sons Limited
    Transazioni
    • 24 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Assignation in security
    Creato il 30 mar 1988
    Consegnato il 07 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    £250,000 deposited in and standing the credit of an amount with the bank.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 21 set 1987
    Consegnato il 25 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    16 woodside crescent glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of covenant
    Creato il 11 mag 1982
    Consegnato il 18 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,765,522 & all further all sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64 shares in the M.V. "stirling teal".
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    First priority statutory mortgage
    Creato il 11 mag 1982
    Consegnato il 18 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64 shares in the M.V. "stirling teal".
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Statutory mortgage
    Creato il 12 ago 1981
    Consegnato il 13 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64 shares in the M.V. "stirling eagle" registered in glasgow nos 364965.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of covenants
    Creato il 28 lug 1981
    Consegnato il 13 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64/64 shares in mv "stirling eagle".
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Deed of covenant
    Creato il 03 lug 1981
    Consegnato il 10 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due but not exceeding £250,000 of principal
    Brevi particolari
    Construction and purchase of a single screw supply vessel to be known during construction as yard no. 119.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Second priority statutory mortgage
    Creato il 03 lug 1981
    Consegnato il 10 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Construction and purchase of a single screw supply vessel to be known during construction as yard no 119.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Financial agreement
    Creato il 03 lug 1981
    Consegnato il 10 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,700,000 & all further moneys due, or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Construction and purchase of a single, screw supply vessel to be known during construction as yard no 119.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 15 ago 1975
    Consegnato il 21 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due from stirling shipping co. LTD. To the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £200,000 deposited with the bank under the terms of the memorandum of deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    WOODSIDE CRESCENT MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 mag 2011Data di scioglimento
    05 giu 2007Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0