CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC034748 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o BDO LLP 70 York Street G2 8JX Glasgow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHRISTIAN SALVESEN (EDINBURGH) LIMITED | 03 nov 1987 | 03 nov 1987 |
| CHRISTIAN SALVESEN (MANAGERS) LIMITED | 05 gen 1960 | 05 gen 1960 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 3 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF a C/O Bdo Llp 70 York Street Glasgow G2 8JX in data 30 nov 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di David James Thomas come amministratore in data 04 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Gavin Evans come amministratore in data 04 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Lyndsay Gillian Navid Lane il 09 mag 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Lyndsay Navid Lane il 09 mag 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David James Thomas come amministratore in data 30 nov 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Bataillard come amministratore in data 27 nov 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gaultier De La Rochebrochard come amministratore in data 29 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Patrick Bataillard come amministratore in data 14 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Ms Lyndsay Gillian Navid Lane come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Lynch come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gaultier Marie Alain Xavier De La Rochebrochard D'auzay il 05 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANE, Lyndsay Navid | Segretario | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7SL Northampton Xpo House England | British | 163371020001 | ||||||
| EVANS, Simon Gavin | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 150758530001 | |||||
| NAVID LANE, Lyndsay Gillian | Amministratore | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7SL Northampton Xpo House England | England | British | 177674310001 | |||||
| GOW, Michael Harper | Segretario | Drummonie House Bridge Of Earn PH2 9HN Perth Tayside | British | 23330001 | ||||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Segretario | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | British | 66121750001 | ||||||
| LAVELLE, James William | Segretario | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Segretario | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | British | 52425370006 | ||||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Segretario | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| ROSE, Ian Andrew | Segretario | Trehern Close Knowle B93 9HA Solihull 3 West Midlands | British | 128431040001 | ||||||
| ASPDEN, Peter Graham | Amministratore | Sandholme Walton Road LE17 5RU Kimcote Leicestershire | England | British | 78527750003 | |||||
| BATAILLARD, Patrick | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Nn5 7sl Xpo House United Kingdom | France | French | 199314850001 | |||||
| BOOTH, Rachel Sarah | Amministratore | 12 The Banks NN11 3BL Everdon Northamptonshire | British | 43448790002 | ||||||
| CARTER, George Robert | Amministratore | A 12 Ravelston Park EH4 3DX Edinburgh Midlothian | British | 40084220001 | ||||||
| DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier | Amministratore | Nd House Lodge Way, New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 163237590002 | |||||
| FIDLER, Brian Harvey | Amministratore | The Eighth House Vernon Avenue OX2 9AU Oxford | England | British | 57282470001 | |||||
| FORD, Sydney John, Dr | Amministratore | Glanmor 37 Ross Avenue Dalgety Bay KY11 5YN Dunfermline Fife | British | 580680002 | ||||||
| GOW, Michael Harper | Amministratore | Drummonie House Bridge Of Earn PH2 9HN Perth Tayside | British | 23330001 | ||||||
| LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 126820460002 | |||||
| LYNCH, David Paul | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | England | British | 52425370006 | |||||
| MCCRAW, James Fraser | Amministratore | 13 Chester Street EH3 7RF Edinburgh | Scotland | British | 19072620002 | |||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Amministratore | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| ROSE, Ian Andrew | Amministratore | Trehern Close Knowle B93 9HA Solihull 3 West Midlands | England | British | 128431040001 | |||||
| SEALEY, Barry Edward | Amministratore | 4 Castlelaw Road EH13 0DN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 23790001 | |||||
| STEWART, John Arnott | Amministratore | 6 Boggs Holdings Pencaitland EH34 5BA Tranent East Lothian | British | 1010140001 | ||||||
| THOMAS, David James | Amministratore | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 147800590002 | |||||
| WADDELL, John Maclaren Ogilvie | Amministratore | 16 Kinghorn Place EH6 4BN Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 113233140001 |
CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee | Creato il 13 mar 1975 Consegnato il 18 mar 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing a grant of 30% of the 2/16TH parts of the cost of having built a new fishing vessel complete with engine and all necessary equipment and all further moneys due, or to become due by ivan boardley & company LTD the chargee - white fish authority | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee by christian salvesen (managers) | Creato il 08 apr 1974 Consegnato il 19 apr 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under said guarantee | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CHRISTIAN SALVESEN CENTRAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0