UA GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUA GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC037130
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UA GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova UA GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UA GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UNITED AUCTIONS (SCOTLAND) PUBLIC LIMITED COMPANY29 dic 196129 dic 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di UA GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per UA GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per UA GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Avviso di fine dell'amministrazione

    13 pagine2.23B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    14 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    14 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    14 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    13 pagine2.20B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    Notifica della domanda di ordinanza di amministrazione

    2.2B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    2.11B(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    1 pagine2.22B(Scot)

    Notifica della domanda di ordinanza di amministrazione

    1 pagine2.2B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    16 pagine2.20B(Scot)

    Proposta dell'amministratore

    80 pagine2.16B(Scot)

    legacy

    1 pagine2.18B(Scot)

    Stato patrimoniale con modulo allegato 2.14B(SCOT)

    18 pagine2.15B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da * Elphinstone House 295 Fenwick Road, Giffnock Glasgow G46 6UH* in data 07 ott 2010

    2 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2009 al 30 giu 2010

    3 pagineAA01

    Dettagli del segretario cambiati per John Keith Martin il 01 giu 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per John Keith Martin il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Kenneth Ross il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Campbell Black il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di UA GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Segretario
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    British45302060001
    BLACK, Campbell
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    United KingdomBritish112031270001
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish45302060001
    ROSS, Kenneth
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritish41012110004
    ADAMSON, Conrad Falconer Patterson
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    Segretario
    5 Windsor Gardens
    EH21 7LP Musselburgh
    Midlothian
    British340760001
    BARNETT, William Macnab
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    Segretario
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    British139680001
    MC WILLIAMS, Arthur Colman
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Segretario
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    American8209240002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Segretario
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Segretario nominato
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BARNETT, William Macnab
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    Amministratore
    Altnabean
    PH11 8DP Alyth
    Perthshire
    British139680001
    CAMERON, John Bell
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    Amministratore
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    ScotlandBritish203550001
    DANSON, David Laurence George
    19/7 South Gray Street
    EH9 1TE Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    19/7 South Gray Street
    EH9 1TE Edinburgh
    Lothian
    British59367160002
    DAVIDSON, Joanna Rosalind, The Hon
    Easter Leckie
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    Amministratore
    Easter Leckie
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    British53039790001
    FRASER, Rowland Lovat
    Parkfield House
    PH2 7PG Perth
    Amministratore
    Parkfield House
    PH2 7PG Perth
    British139690001
    GRAHAME, Joan Suzanne
    19 Barclay Place
    FK15 0FB Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    19 Barclay Place
    FK15 0FB Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish75723440003
    HALLEY, Peter
    Lochlane
    PH7 4HT Crieff
    Perthshire
    Amministratore
    Lochlane
    PH7 4HT Crieff
    Perthshire
    British352400002
    IZAT, Alexander John Rennie
    High
    Cocklaw
    TD15 1UZ Berwick-Upon-Tweed
    Amministratore
    High
    Cocklaw
    TD15 1UZ Berwick-Upon-Tweed
    EnglandBritish52978120002
    LEGGAT, Hugh David
    Garry Cottage
    Bankfoot
    PH1 4AT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Garry Cottage
    Bankfoot
    PH1 4AT Perth
    Perthshire
    PerthBritish686400001
    LINDSAY, James Randolph, Earl Of Lindsay
    Lahill House
    Upper Largo
    KY8 6JE Leven
    Fife
    Amministratore
    Lahill House
    Upper Largo
    KY8 6JE Leven
    Fife
    ScotlandBritish65541090001
    MC WILLIAMS, Arthur Colman
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Amministratore
    2 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    American8209240002
    MCGREGOR, Alan James Robley
    Muirhead
    Rhynd
    PH2 8QE Perth
    Amministratore
    Muirhead
    Rhynd
    PH2 8QE Perth
    ScotlandBritish56420760001
    MCKENZIE, Norman Donald
    Dunkirk Park
    Bridge Of Earn
    PH2 9DY Perth
    Amministratore
    Dunkirk Park
    Bridge Of Earn
    PH2 9DY Perth
    British686420001
    MITCHELL, Arthur Nicoll
    Leuchars Castle
    Fife
    Amministratore
    Leuchars Castle
    Fife
    British641370001
    MITCHELL, Colin Henry Whiteford
    Ardtornish
    Strathkinness Road
    KY16 9UB St Andrews
    Fife
    Amministratore
    Ardtornish
    Strathkinness Road
    KY16 9UB St Andrews
    Fife
    British37779160001
    MONCREIFFE, Peregrine David Euan Malcolm, Hon
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    Amministratore
    Easter Moncreiffe
    PH2 8QA Bridge Of Earn
    Perthshire
    British79267610001
    SANDERSON, Charles Russell, Lord
    Beckettsfield
    Bowden
    TD6 0ST Melrose
    Roxburghshire
    Amministratore
    Beckettsfield
    Bowden
    TD6 0ST Melrose
    Roxburghshire
    ScotlandBritish1362030001
    STRACHAN, Arthur Morton
    Avondale
    52 Roman Way
    FK15 9DJ Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Avondale
    52 Roman Way
    FK15 9DJ Dunblane
    Perthshire
    British74545880001
    TOUGH, Kenneth Liddell
    17 Elphinstone Road
    Giffnock
    G46 6TF Glasgow
    Amministratore
    17 Elphinstone Road
    Giffnock
    G46 6TF Glasgow
    United KingdomBritish33189110001
    WEIR, James
    Netherby
    FK9 4 Bridge Of Allan
    Amministratore
    Netherby
    FK9 4 Bridge Of Allan
    British448970001
    WIGHT, John James
    Midlock
    Crawford
    ML12 6UA Biggar
    Lanarkshire
    Amministratore
    Midlock
    Crawford
    ML12 6UA Biggar
    Lanarkshire
    ScotlandScottish37316580001
    YOUNG, Charles Whiteford
    8 Succoth Place
    EH12 6BL Edinburgh
    Amministratore
    8 Succoth Place
    EH12 6BL Edinburgh
    British4667770001

    UA GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 13 mag 2005
    Consegnato il 25 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond dated 9 may 2005
    Brevi particolari
    Subjects at polmaise, stirling.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Kildean auction mart and adjacent premises, stirling.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    9.374 hectares at slackbuie, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.761 hectares at slackbuie, inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Perth agricultural centre, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    West haugh, stirling.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 27 apr 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at woodmarket and abbey row, kelso.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of land at slackbuie, near inverness comprehending the farms of upper and lower slackbuie.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7.975 acres at lairg on south east side of public road to from lairg to bonar bridge under exception.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Broxy kennels, redgorton, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Denmarkfield, redgorton, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    St. Magdalene's, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at rosebank, balmoral road, rattray.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at south road, cupar known as bells brae.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.7 hectares at lairg.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Auction mart premises at ormlie road, thurso.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 07 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Auction mart premises at norland road, lybster, caithness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    Mart field, dalmally (title number ARG1080) and dalmally auction mart, dalmally (title number ARG1081).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    Huntly auction mart, huntly (title number ABN71710).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    Ground at woodlands terrace/beachan wood, grantown on spey (title number MOR3360).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    Farm and lands of milton of banniskirk, near thurso, caithness.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    Subjects at glenshellach, oban.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 18 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due in terms of the personal bond
    Brevi particolari
    Lands of moleigh, oban.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 12 lug 1994
    Consegnato il 29 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000
    Brevi particolari
    7.88 acres at torbrex, st. Ninians, stirling lying to the south of torbrex road, stirling bounded to the south or southmost by the farm and lands of coxithill (otherwise coxet hill) owned by the firm of john oswald and son, which area of ground is shown delineated in red on the plan annexed and signed as relative to the standard security recorde 12TH july 1994.
    Persone aventi diritto
    • Wimpey Homes Holdings Limited
    Transazioni
    • 29 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 22 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 mag 1988
    Consegnato il 27 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Cattlemarket at caledonia road and elibank street, perth (part of lands of greenyards) 296/302 high street, perth ground immediately to west of 296/302 high street, perth ground at high street, perth (formerly 316/320 high street, perth) "clayholes" at high street/elibank street, perth ground at high street/elibank street, perth.
    Persone aventi diritto
    • Ccl LTD
    Transazioni
    • 27 mag 1988Registrazione di un'ipoteca

    UA GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 set 2010Inizio dell'amministrazione
    01 set 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praticante
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praticante
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    2
    DataTipo
    24 set 2010Inizio dell'amministrazione
    27 set 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praticante
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Praticante
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0