COMPCO HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | COMPCO HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC037323 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COMPCO HOLDINGS LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova COMPCO HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Level 4 Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COMPCO HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
COMPCO HOLDINGS PLC | 08 mar 1962 | 08 mar 1962 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COMPCO HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per COMPCO HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Steven Ross Collins come amministratore in data 18 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Niki Maxine Cole come amministratore in data 18 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mrs Niki Cole come amministratore in data 30 giu 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Terence Shelby Cole come amministratore in data 30 giu 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021 | 7 pagine | AA | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 11 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 14 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Richard Jeremy De Barr come segretario in data 23 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Chi sono gli amministratori di COMPCO HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEINBERG, Mark Neil | Amministratore | Wadham Gardens NW3 3DN London 11 | United Kingdom | British | Company Director | 59275730001 | ||||
DE BARR, Richard Jeremy | Segretario | 38 Tring Avenue W5 3QB London | British | 43885410001 | ||||||
MCPAKE, Ian Alan Herbert | Segretario | 66 Queen Street EH2 4NE Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 1087400003 | |||||
RANKEN & REID SSC | Segretario | 7 Albyn Place EH2 4NG Edinburgh Midlothian | 36900001 | |||||||
ANDERSON, Bruce Smith | Amministratore | 2 Bramdean View EH10 6JX Edinburgh | Scotland | British | Director | 73849040001 | ||||
BUTTON, John Martin | Amministratore | Highclere Coin Colin, St. Martin GY4 6AQ Guernsey Channel Islands | British | Banker | 8959490001 | |||||
COLE, Niki Maxine | Amministratore | Level 4 Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | United Kingdom | British | Director | 303564480001 | ||||
COLE, Terence Shelby | Amministratore | Upper Berkeley Street W1H 7PE London 10 England | United Kingdom | British | Company Director | 71810060003 | ||||
COLLINS, Steven Ross | Amministratore | Bulstrode Street W1U 2JH London 17 England | England | British | Company Director | 7128850005 | ||||
HOWES, Christopher Kingston, Sir | Amministratore | Westerly House IP15 5EL Aldeburgh Suffolk | England | British | Chartered Surveyor | 84824340001 | ||||
JAYE, Andrew Ian | Amministratore | Weatheroak The Common HA7 3HP Stanmore Middlesex | England | British | Estate Agent | 10174290002 | ||||
LEAVER, Brian Ivan | Amministratore | The Garden House 72 Paines Lane HA5 3BL Pinner Middlesex | England | British | Director | 13082210001 | ||||
LEHMANN, Colin Ivor | Amministratore | 25 Totteridge Village N20 8PN London | England | British | Company Director | 43173670002 | ||||
LEWIS, Philip Geoffrey | Amministratore | 1 Parkside NW7 2LJ London | England | British | Chartered Surveyor | 6639590001 | ||||
MYERS, Bernard Ian | Amministratore | New Court St Swithins Lane EC4P 4DU London | United Kingdom | British | Consultant | 47627350005 | ||||
NADLER, John Esmond | Amministratore | Flat 4 Essex Court 30 St James Place SW1 London | British | Chartered Surveyor | 1791570001 | |||||
NADLER, Robert Arthur | Amministratore | 123 Old Church Street SW3 6EA London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 33752790002 | ||||
PICKFORD, David Michael | Amministratore | Elm Tree Farm Mersham TN25 7HS Ashford Kent | British | Chartered Surveyor | 64475900002 | |||||
ROSS, Nigel Keith | Amministratore | 60 Cumberland Terrace NW1 4HJ London | United Kingdom | British | Director | 47878830001 | ||||
RUBENS, Kenneth David | Amministratore | 61 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 35531750001 | ||||
WOLFSON OF SUNNINGDALE, David, Lord | Amministratore | 1 Portobello Studios Haydens Place W11 1LY London | England | British | Director | 92063640001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COMPCO HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
City & General Securities Ltd | 06 apr 2016 | Upper Berkeley Street W1H 7PE London 10 England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
COMPCO HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and confirmation | Creato il 26 mar 2012 Consegnato il 10 apr 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of confirmation | Creato il 26 mar 2012 Consegnato il 10 apr 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole property (including uncalled capital) which is or may be from time to time while the floating charge is in force comprised in the property and undertaking of the chargor. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 26 mar 2012 Consegnato il 10 apr 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Debenture | Creato il 26 mar 2012 Consegnato il 10 apr 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 set 2003 Consegnato il 23 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under the charge, each of the facility agreements and each of the other finance documents | |
Brevi particolari First legal mortgage, first fixed charge and floating charge over assets. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 04 set 2003 Consegnato il 23 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due under each finance document | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Legal charge | Creato il 10 dic 1999 Consegnato il 16 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Property at madeira drive, brighton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Third party deed of charge over shareholders' loans | Creato il 19 ott 1995 Consegnato il 06 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All the company's present and future rights, title and interest in and to the sum of £350,000 together with any interest arising from a loan in connection with the purchase of property at 9 bridge street, newport. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & floating charge | Creato il 19 set 1967 Consegnato il 25 set 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the said guarantee by the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £80,000 deposited by the company with the chargee & all moneys now or hereafter standing to the credit of the company's deposit accounts with the chargee up to the sum of £80,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0