CASTLEGAIT HOMES LIMITED

CASTLEGAIT HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEGAIT HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC038429
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CASTLEGATE HOMES LIMITED08 ott 200108 ott 2001
    KILMARTIN HOMES LTD.20 dic 199920 dic 1999
    CHARLES GRAY (HOMES) LIMITED13 feb 196313 feb 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2021 al 30 apr 2021

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2021 al 30 giu 2021

    1 pagineAA01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Colin Edward Lewis come amministratore in data 30 apr 2021

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 25 mar 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 mag 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 02 lug 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 mag 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di David Jonathan Knight come amministratore in data 28 feb 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 apr 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    legacy

    1 pagineAC93

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    8 pagineAA

    Nomina di Mr David Jonathan Knight come amministratore in data 21 nov 2016

    2 pagineAP01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Chi sono gli amministratori di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Segretario
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809040001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    BLACK, Thelma
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    Segretario
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    British40275440001
    BLACK, Thelma
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    Segretario
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    British40275440001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    HASSAN, Brian
    33 Murray Street
    DD4 7JG Dundee
    Angus
    Segretario
    33 Murray Street
    DD4 7JG Dundee
    Angus
    Brittish1151560001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    LEES, Gordon
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    Segretario
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    British82127910001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    MCGUIRE, Hugh Keenan
    25 Ferry Road
    Monifieth
    DD5 4NS Dundee
    Angus
    Segretario
    25 Ferry Road
    Monifieth
    DD5 4NS Dundee
    Angus
    British544160001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Segretario
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Segretario
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    ROLLO STEVEN & BOND SOLICITORS
    21 Dock Street
    DD1 3DS Dundee
    Segretario
    21 Dock Street
    DD1 3DS Dundee
    871680002
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Amministratore
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Amministratore
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    British1198020003
    BROWN, Andrew
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandScottish91209410001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COOPER, James Arthur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    British43500170001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    EDWARDS, David Reginald
    28 Linn Mill
    South Queensferry
    EH30 9ST Edinburgh
    West Lothian
    Amministratore
    28 Linn Mill
    South Queensferry
    EH30 9ST Edinburgh
    West Lothian
    British110601800001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FRASER, Gordon Mackenzie
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    Amministratore
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    British16138750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GRAY, Robert Stirton
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    Amministratore
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    British544170001
    GRAY, Robert Stirton
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    Amministratore
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    British544170001
    GRAY, Robert Stirton
    Stonewell House
    Muirhead
    DD2 5QR Dundee
    Amministratore
    Stonewell House
    Muirhead
    DD2 5QR Dundee
    British39966980001
    HODGE, Barry George
    7 Dullatur Road
    G68 0AF Dullatur
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Dullatur Road
    G68 0AF Dullatur
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102707890001
    KENNEDY, David Samuel
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    Amministratore
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    British93176930001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    KNIGHT, David Jonathan
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish190746580001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    MACCOLL, Stuart Neil
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish111800560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House 6 And 9
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House 6 And 9
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03215228
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CASTLEGAIT HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 13 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Former sub station site lying to the west of arkleston road, paisley.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 09 ott 2003
    Consegnato il 14 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land adjacent to public road at balgowan, perthshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 09 ott 2003
    Consegnato il 14 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Part of balgowan sawmill and adjacent land at balgowan, perthshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 25 set 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects at barshaw drive, paisley REN111616.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 23 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at old gartloch road, gartcosh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.1 hectares at arkleston road, paisley.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 16 giu 2003
    Consegnato il 27 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.418 acres at calderpark zoo, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 06 dic 2002
    Consegnato il 12 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The tinto firs hotel and ground attached at 470-472 kilmarnock road, newlands, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    20-28 (even numbers) robertson street, glasgow and 13-33 (odd numbers) and 39 and 41 oswald street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Assignation of standard security
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In security of the obligations contained within the missives dated 8 and 9 august 2002
    Brevi particolari
    45/51 oswald street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 ago 2002
    Consegnato il 22 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of condition 14 of the agreement constituted by missives dated 8 and 9 august 2002
    Brevi particolari
    20, 22, 24, 26 and 28 robertson street, glasgow 13 to 33 (odd numbers) and 39 oswald street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Ppg Metro Oswald Limited
    Transazioni
    • 22 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 15 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.125 hectares at balmullo,fife.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 01 lug 2002
    Consegnato il 10 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 24 june 2002
    Brevi particolari
    Former limb fitting centre, queen street, broughty ferry, dundee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 apr 2002
    Consegnato il 13 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due in terms of a personal bond dated 21 march 2002
    Brevi particolari
    Land at east kirkton, arbroath (title numbers ANG9112 & ANG10451).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 08 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 11 set 2000
    Consegnato il 15 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground to the north side of south william street, perth.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 set 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 27 lug 1999
    Consegnato il 30 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground at reform street and lying to the west of craig lane, tayport.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 26 apr 1999
    Consegnato il 05 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground in anstruther, fife lying to east of waid academy sports field.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 16 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 13 mag 1998
    Consegnato il 27 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.7174 hectares of ground at spearshill road,tayport,fife.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 giu 1996
    Consegnato il 27 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.050 hectares of land at crail road, anstruther, fife.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 ott 1995
    Consegnato il 31 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ogilvie road,broughty ferry,dundee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 14 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £206,250
    Brevi particolari
    The site of the former dunella hotel, albany road, broughty ferry, dundee.
    Persone aventi diritto
    • Trojan Metals Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 06 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Dunella hotel,albany road,broughty ferry,dundee.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0