CASTLEGAIT HOMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CASTLEGAIT HOMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC038429 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CASTLEGATE HOMES LIMITED | 08 ott 2001 | 08 ott 2001 |
| KILMARTIN HOMES LTD. | 20 dic 1999 | 20 dic 1999 |
| CHARLES GRAY (HOMES) LIMITED | 13 feb 1963 | 13 feb 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2021 al 30 apr 2021 | 1 pagine | AA01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2021 al 30 giu 2021 | 1 pagine | AA01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Colin Edward Lewis come amministratore in data 30 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 25 mar 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 01 mag 2020 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 02 lug 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 03 mag 2019 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di David Jonathan Knight come amministratore in data 28 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 27 apr 2018 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 giu 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||
legacy | 1 pagine | AC93 | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 8 pagine | AA | ||
Nomina di Mr David Jonathan Knight come amministratore in data 21 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Chi sono gli amministratori di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Segretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | 147809040001 | |||||||
| SHARP, Giles Henry | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| BLACK, Thelma | Segretario | Flat 20 99 Strathmartine Rd DD3 7RY Dundee | British | 40275440001 | ||||||
| BLACK, Thelma | Segretario | Flat 20 99 Strathmartine Rd DD3 7RY Dundee | British | 40275440001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Segretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| HASSAN, Brian | Segretario | 33 Murray Street DD4 7JG Dundee Angus | Brittish | 1151560001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Segretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| LEES, Gordon | Segretario | 8 Grange Gardens Monifieth DD5 4NA Tayside | British | 82127910001 | ||||||
| MASON, Eddie Roy | Segretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
| MCGUIRE, Hugh Keenan | Segretario | 25 Ferry Road Monifieth DD5 4NS Dundee Angus | British | 544160001 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Segretario | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| URQUHART, Roderick Macduff | Segretario | The Hall Samuelston EH41 4HG Haddington E Lothian | British | 562500001 | ||||||
| ROLLO STEVEN & BOND SOLICITORS | Segretario | 21 Dock Street DD1 3DS Dundee | 871680002 | |||||||
| BEAZER, Anthony Hadyn | Amministratore | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | 91412650001 | |||||
| BETHUNE, Hamish William | Amministratore | Auchenross PH6 2JU Comrie Perthshire | British | 1198020003 | ||||||
| BROWN, Andrew | Amministratore | 5 Strathcarron Way PA2 7AE Paisley Renfrewshire | Scotland | Scottish | 91209410001 | |||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| COOPER, James Arthur | Amministratore | 4 Maclean Grove East Kilbride G74 4TJ Glasgow Lanarkshire | British | 43500170001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Amministratore | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Amministratore | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| EDWARDS, David Reginald | Amministratore | 28 Linn Mill South Queensferry EH30 9ST Edinburgh West Lothian | British | 110601800001 | ||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| FRASER, Gordon Mackenzie | Amministratore | Cortachy Cottage Auchterhouse Dundee | British | 16138750005 | ||||||
| GAFFNEY, David | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Amministratore | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GRAY, Robert Stirton | Amministratore | 506 Perth Road DD2 1LS Dundee Angus | British | 544170001 | ||||||
| GRAY, Robert Stirton | Amministratore | 506 Perth Road DD2 1LS Dundee Angus | British | 544170001 | ||||||
| GRAY, Robert Stirton | Amministratore | Stonewell House Muirhead DD2 5QR Dundee | British | 39966980001 | ||||||
| HODGE, Barry George | Amministratore | 7 Dullatur Road G68 0AF Dullatur Lanarkshire | United Kingdom | British | 102707890001 | |||||
| KENNEDY, David Samuel | Amministratore | 1 Glebe Gardens EH12 7SG Edinburgh | British | 93176930001 | ||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Amministratore | Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow 35 Lanarkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| KNIGHT, David Jonathan | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 190746580001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| MACCOLL, Stuart Neil | Amministratore | 47 Murieston Valley Murieston EH54 9HJ Livingston West Lothian | Scotland | British | 111800560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEGAIT HOMES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant Homes Limited | 06 apr 2016 | Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House 6 And 9 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CASTLEGAIT HOMES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 14 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 08 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 13 feb 2004 Consegnato il 04 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Former sub station site lying to the west of arkleston road, paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 ott 2003 Consegnato il 14 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land adjacent to public road at balgowan, perthshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 09 ott 2003 Consegnato il 14 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Part of balgowan sawmill and adjacent land at balgowan, perthshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 25 set 2003 Consegnato il 10 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects at barshaw drive, paisley REN111616. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 set 2003 Consegnato il 01 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land at old gartloch road, gartcosh. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 03 set 2003 Consegnato il 11 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 2.1 hectares at arkleston road, paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 16 giu 2003 Consegnato il 27 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1.418 acres at calderpark zoo, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 06 dic 2002 Consegnato il 12 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The tinto firs hotel and ground attached at 470-472 kilmarnock road, newlands, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 19 ago 2002 Consegnato il 22 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 20-28 (even numbers) robertson street, glasgow and 13-33 (odd numbers) and 39 and 41 oswald street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of standard security | Creato il 19 ago 2002 Consegnato il 22 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In security of the obligations contained within the missives dated 8 and 9 august 2002 | |
Brevi particolari 45/51 oswald street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 19 ago 2002 Consegnato il 22 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due in terms of condition 14 of the agreement constituted by missives dated 8 and 9 august 2002 | |
Brevi particolari 20, 22, 24, 26 and 28 robertson street, glasgow 13 to 33 (odd numbers) and 39 oswald street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 03 lug 2002 Consegnato il 15 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1.125 hectares at balmullo,fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 01 lug 2002 Consegnato il 10 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due in terms of a personal bond dated 24 june 2002 | |
Brevi particolari Former limb fitting centre, queen street, broughty ferry, dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 apr 2002 Consegnato il 13 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due in terms of a personal bond dated 21 march 2002 | |
Brevi particolari Land at east kirkton, arbroath (title numbers ANG9112 & ANG10451). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 26 set 2001 Consegnato il 08 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 11 set 2000 Consegnato il 15 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground to the north side of south william street, perth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 27 lug 1999 Consegnato il 30 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground at reform street and lying to the west of craig lane, tayport. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 26 apr 1999 Consegnato il 05 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground in anstruther, fife lying to east of waid academy sports field. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 13 mag 1998 Consegnato il 27 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 0.7174 hectares of ground at spearshill road,tayport,fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 20 giu 1996 Consegnato il 27 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1.050 hectares of land at crail road, anstruther, fife. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 20 ott 1995 Consegnato il 31 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ogilvie road,broughty ferry,dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 26 mag 1995 Consegnato il 14 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £206,250 | |
Brevi particolari The site of the former dunella hotel, albany road, broughty ferry, dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 26 mag 1995 Consegnato il 06 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Dunella hotel,albany road,broughty ferry,dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0