GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC039207 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Argyll Court The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Scotland Scotland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BETT HOMES (NORTH WEST) LIMITED | 05 mar 2003 | 05 mar 2003 |
| BETT HOMES (NORTHERN) LIMITED | 06 ott 1995 | 06 ott 1995 |
| BETT DEVELOPMENTS LIMITED | 16 mag 1986 | 16 mag 1986 |
| CHARLES E. SPALDING (PROPERTIES) LIMITED | 03 set 1963 | 03 set 1963 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 11 dic 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Glyn David Mabey il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT in data 23 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 20 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 18 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 17 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 16 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 15 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Segretario | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | 147809270001 | |||||||
| LEWIS, Colin Edward | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| MABEY, Glyn David | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | Wales | British | 100945610001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Amministratore | The Castle Business Park FK9 4TT Stirling Argyll Court Scotland Scotland | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Segretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Segretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MASON, Eddie Roy | Segretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
| ANDERSON, Alexander | Amministratore | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||
| ASKER, Giles Allen Trevor | Amministratore | Nicholas Way Corringham DN21 5QE Gainsborough 9 Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75879360004 | |||||
| BALL, Malcolm | Amministratore | 6 Bowline Close CW11 4AQ Sandbach Cheshire | Great Britain | British | 107732120001 | |||||
| BETT, Iain Charles Rattray | Amministratore | Kingennie House Kingennie DD5 3RD Dundee | Scotland | British | 95179330001 | |||||
| BURTON, Christopher Julian | Amministratore | 5 The Heatherways CW6 0HP Tarporley Cheshire | British | 71961290002 | ||||||
| CALDER, John Murray | Amministratore | 69 Camphill Road Broughty Ferry DD5 2LY Dundee | British | 318650001 | ||||||
| CALDWELL, Denise Elsie | Amministratore | 14 The Hillock Astley M29 7GW Manchester Lancashire | British | 122926060001 | ||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| COLLS, Andrew John | Amministratore | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 61370150001 | |||||
| CORRIN, Brian Stanley | Amministratore | 14 Ward Close Great Sankey WA5 8XY Warrington Cheshire | England | British | 110416140001 | |||||
| DIPRE, John Vivian | Amministratore | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Amministratore | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Amministratore | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GIBSON, Alexander | Amministratore | 117 Strathern Road Broughty Ferry DD5 1JR Dundee Angus | British | 318180001 | ||||||
| GORE, Derek Cyril | Amministratore | 15 Rockfield Crescent DD2 1JF Dundee Tayside | British | 92043160001 | ||||||
| GRANT, Alexander James | Amministratore | 52 Wester Inshes Court IV2 5HS Inverness Inverness Shire | British | 107801990001 | ||||||
| GRIFFIN, Stephen Barry | Amministratore | 29 Little Acton Drive Garden Village LL12 8DH Wrexham N Wales | British | 66519990002 | ||||||
| HANDYSIDE, Mark | Amministratore | 11 Lawn Park Milngavie G62 6HG Glasgow Lanarkshire | British | 56712320001 | ||||||
| HANNA, Ronald George | Amministratore | 34 Primrose Bank Road EH5 3JF Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 8506940001 | |||||
| HIRST, Stephen Jeremy | Amministratore | Folds Lane S8 0ET Sheffield 157 United Kingdom | United Kingdom | British | 95787000001 | |||||
| KELLY, Richard Ian | Amministratore | 30 Wood Lane WA15 7PS Timperley Cheshire | United Kingdom | British | 157317280001 | |||||
| LANCASTER, Michaela Dawn | Amministratore | 2 Highmoor Park BB7 1JB Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | 79770560001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Amministratore | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LAW, Ronald Douglas | Amministratore | 7 Burns Avenue FK5 4FB Larbert | British | 67443350001 | ||||||
| MITCHELL, Ronald | Amministratore | 7 Albert Road Broughty Ferry DD5 1AY Dundee Angus | British | 318190001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Amministratore | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 207729000002 |
GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 01 set 2009 Consegnato il 16 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Shares pledge | Creato il 01 set 2009 Consegnato il 15 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 2 ordinary shares in gladedale (dundee) limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shares pledge | Creato il 01 set 2009 Consegnato il 15 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1,000 ordinary shares in gladedale (central scotland) limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 01 set 2009 Consegnato il 15 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Share pledge | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 14 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Entire right, title and interest (present and future) to the shares. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 14 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 30 dic 2008 Consegnato il 08 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Floating charge | Creato il 21 mag 2003 Consegnato il 03 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 giu 1990 Consegnato il 25 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ironbank car park site, east side thorpe road staines sy 566260. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 gen 1990 Consegnato il 29 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Freehold property known as tudor lodge, king harry st, hemal hempstead, hertfordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 mag 1989 Consegnato il 18 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot 8, south partway business park, old sarom, laverstock, wiltshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 mar 1989 Consegnato il 10 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 | |
Brevi particolari 120 west campbell street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 dic 1988 Consegnato il 10 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land north west side crabtree road thorpe part sy 535529 sy 485155 sy 489268. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 08 dic 1988 Consegnato il 22 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land at crabtree road, thorpe nr. Staines, middlesex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 22 lug 1987 Consegnato il 04 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground in the city of glasgow and county of the barony and regality of glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 02 feb 1987 Consegnato il 06 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1,029.59 square metres in kilmarnock ayrshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of offset | Creato il 10 apr 1984 Consegnato il 24 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and or others | |
Brevi particolari Balances at credit of any account held by the bank of scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0