GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED

GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC039207
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BETT HOMES (NORTH WEST) LIMITED 05 mar 200305 mar 2003
    BETT HOMES (NORTHERN) LIMITED06 ott 199506 ott 1995
    BETT DEVELOPMENTS LIMITED16 mag 198616 mag 1986
    CHARLES E. SPALDING (PROPERTIES) LIMITED03 set 196303 set 1963

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 dic 2015

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Glyn David Mabey il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Edward Lewis il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mar 2015

    Stato del capitale al 12 mar 2015

    • Capitale: GBP 12,016,000
    SH01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Segretario
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809270001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    MABEY, Glyn David
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesBritish100945610001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    ASKER, Giles Allen Trevor
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nicholas Way
    Corringham
    DN21 5QE Gainsborough
    9
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish75879360004
    BALL, Malcolm
    6 Bowline Close
    CW11 4AQ Sandbach
    Cheshire
    Amministratore
    6 Bowline Close
    CW11 4AQ Sandbach
    Cheshire
    Great BritainBritish107732120001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Amministratore
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    BURTON, Christopher Julian
    5 The Heatherways
    CW6 0HP Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    5 The Heatherways
    CW6 0HP Tarporley
    Cheshire
    British71961290002
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Amministratore
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    CALDWELL, Denise Elsie
    14 The Hillock
    Astley
    M29 7GW Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    14 The Hillock
    Astley
    M29 7GW Manchester
    Lancashire
    British122926060001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COLLS, Andrew John
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish61370150001
    CORRIN, Brian Stanley
    14 Ward Close
    Great Sankey
    WA5 8XY Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    14 Ward Close
    Great Sankey
    WA5 8XY Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish110416140001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Amministratore
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GORE, Derek Cyril
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    Amministratore
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    British92043160001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    GRIFFIN, Stephen Barry
    29 Little Acton Drive
    Garden Village
    LL12 8DH Wrexham
    N Wales
    Amministratore
    29 Little Acton Drive
    Garden Village
    LL12 8DH Wrexham
    N Wales
    British66519990002
    HANDYSIDE, Mark
    11 Lawn Park
    Milngavie
    G62 6HG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Lawn Park
    Milngavie
    G62 6HG Glasgow
    Lanarkshire
    British56712320001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    HIRST, Stephen Jeremy
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    Amministratore
    Folds Lane
    S8 0ET Sheffield
    157
    United Kingdom
    United KingdomBritish95787000001
    KELLY, Richard Ian
    30 Wood Lane
    WA15 7PS Timperley
    Cheshire
    Amministratore
    30 Wood Lane
    WA15 7PS Timperley
    Cheshire
    United KingdomBritish157317280001
    LANCASTER, Michaela Dawn
    2 Highmoor Park
    BB7 1JB Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    2 Highmoor Park
    BB7 1JB Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish79770560001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LAW, Ronald Douglas
    7 Burns Avenue
    FK5 4FB Larbert
    Amministratore
    7 Burns Avenue
    FK5 4FB Larbert
    British67443350001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Amministratore
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    GLADEDALE (NORTH WEST) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 16 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 24 feb 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (MG05s)
    • 24 feb 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (MG05s)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Shares pledge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2 ordinary shares in gladedale (dundee) limited.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Shares pledge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1,000 ordinary shares in gladedale (central scotland) limited.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Share pledge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Entire right, title and interest (present and future) to the shares.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 21 mag 2003
    Consegnato il 03 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Legal charge
    Creato il 18 giu 1990
    Consegnato il 25 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ironbank car park site, east side thorpe road staines sy 566260.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1990
    Consegnato il 29 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Freehold property known as tudor lodge, king harry st, hemal hempstead, hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 mag 1989
    Consegnato il 18 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plot 8, south partway business park, old sarom, laverstock, wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 23 mar 1989
    Consegnato il 10 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000
    Brevi particolari
    120 west campbell street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Birnam Securities (Glasgow) Limited
    Transazioni
    • 10 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 dic 1988
    Consegnato il 10 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land north west side crabtree road thorpe part sy 535529 sy 485155 sy 489268.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 08 dic 1988
    Consegnato il 22 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at crabtree road, thorpe nr. Staines, middlesex.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 22 lug 1987
    Consegnato il 04 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground in the city of glasgow and county of the barony and regality of glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 02 feb 1987
    Consegnato il 06 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1,029.59 square metres in kilmarnock ayrshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of offset
    Creato il 10 apr 1984
    Consegnato il 24 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and or others
    Brevi particolari
    Balances at credit of any account held by the bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0