BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED

BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC041450
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUDGET EXHAUSTS & TYRES LIMITED 17 giu 199117 giu 1991
    BUDGET TYRES & EXHAUSTS LIMITED 05 apr 198405 apr 1984
    THISTLE METALLICS LIMITED10 dic 196410 dic 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 05 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2012

    Stato del capitale al 25 giu 2012

    • Capitale: GBP 100,020
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Kazushi Ogura come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Kenji Murai come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Healy come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Fraser come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Healy come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Ian Vincent Ellis come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 05 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Ellis Fraser il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Ian Vincent
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    Segretario
    216 East Main Street
    Broxburn
    EH52 5AS West Lothian
    British162126270001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Segretario
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    HUTHERSALL, Robert
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Segretario
    17 Corstorphine Road
    EH12 6DD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British3204110001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Segretario
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Amministratore
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    FARMER, Thomas, Sir
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    Amministratore
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    ScotlandBritish94804240004
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Amministratore
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    British712840002
    HUTHERSALL, Robert
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    Amministratore
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    British3204110005
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Amministratore
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001

    BUDGET TYRE PLUS AUTOSERVICE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of agreement
    Creato il 10 gen 1983
    Consegnato il 14 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums standing at the credit of the company with the bank on current account or otherwise.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 dic 1982
    Consegnato il 06 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    14/20 brown street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 03 set 1982
    Consegnato il 10 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    123/125 causeway end, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 03 giu 1982
    Consegnato il 15 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0