ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED

ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC041535
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3-4 Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALLOA BREWERY COMPANY LIMITED25 gen 199325 gen 1993
    IBROX HOUSE LIMITED30 dic 196430 dic 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    94 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT1

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium account 20/05/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    86 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    2 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere SC0415350009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    United Kingdom
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinance Director257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627630001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175480510001
    HASTIE, David William
    32 The Green
    Pencaitland
    EH34 5HE Tranent
    East Lothian
    Segretario
    32 The Green
    Pencaitland
    EH34 5HE Tranent
    East Lothian
    British34013710002
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    SKEATES, Alan John
    Rhelonie
    Jerusalem
    EH34 4BQ Pencaitland
    East Lothian
    Scotland
    Segretario
    Rhelonie
    Jerusalem
    EH34 4BQ Pencaitland
    East Lothian
    Scotland
    British649690003
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161615990001
    AITKEN, Robert
    Medway 7 The Dean
    EH40 3ED East Linton
    East Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Medway 7 The Dean
    EH40 3ED East Linton
    East Lothian
    Scotland
    BritishCompany Director16212230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishSecretary637110001
    CAMPBELL, John
    41 Craiglockhart Loan
    EH14 1JR Edinburgh
    Amministratore
    41 Craiglockhart Loan
    EH14 1JR Edinburgh
    BritishDirector34013860001
    CAMPBELL, Kenneth
    Rosemount 9 Swansacre
    KY13 7TE Kinross
    Fife
    Amministratore
    Rosemount 9 Swansacre
    KY13 7TE Kinross
    Fife
    BritishDirector649700001
    CONSTANTINE, Peter Anthony
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishCsu/Estates Director114160540001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector180590780001
    GREVILLE WILLIAMS, Jeremy Aubrey
    Peastonbank Farmhouse
    EH34 5ET Pencaitland
    East Lothian
    Amministratore
    Peastonbank Farmhouse
    EH34 5ET Pencaitland
    East Lothian
    BritishCompany Director44110280002
    HARDIE, James Allan
    Bourtri 5 Glen Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4PN Stirling
    Stirlingshire
    Scotland
    Amministratore
    Bourtri 5 Glen Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4PN Stirling
    Stirlingshire
    Scotland
    ScotlandBritishBrewer649720001
    JELBERT, Brian
    Slingsby Lodge
    Old Scriven
    HG5 9DZ Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Slingsby Lodge
    Old Scriven
    HG5 9DZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director14393610002
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    BritishDirector29595900002
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Amministratore
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritishDirector79388130005
    MACKENZIE, John Saffery
    The Old Manse
    Elsrickle
    Biggar
    Scotland
    Amministratore
    The Old Manse
    Elsrickle
    Biggar
    Scotland
    BritishCompany Director649730001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCDONALD, Robert James
    24 Ross Avenue
    Dalgety Bay
    KY11 5YN Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    24 Ross Avenue
    Dalgety Bay
    KY11 5YN Dunfermline
    Fife
    BritishAccountant9489780002
    MCKEOWN, John Wilson
    1 Swithland Lane
    LE7 7SG Rothley
    Leicestershire
    Amministratore
    1 Swithland Lane
    LE7 7SG Rothley
    Leicestershire
    BritishCompany Director2126530001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector237381690001
    TRIGG, John Anthony Fitzgerald
    Bovingdon Ash Chipperfield Road
    Bovingdon
    HP3 0JW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bovingdon Ash Chipperfield Road
    Bovingdon
    HP3 0JW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishDirector9489710001
    WILKINSON, Anthony Eric
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director4656080002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc065527
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Punch Taverns (Rh) Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ALLOA PUBS & RESTAURANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 ott 2014
    Consegnato il 15 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited as Security Trustee for the Punch Taverns Secured Parties
    Transazioni
    • 15 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third supplemental deed of charge
    Creato il 03 nov 2003
    Consegnato il 24 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Further punch taverns mortgaged properties being chetwynd arms, upper longdon, rugeley; horse & jockey, tamworth road, freeford, lichfirld and other properties. See form 410 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 24 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge
    Creato il 22 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Assignment by way of first fixed security of all the company's right, title, benefit and interest, present and future in, to and under the master amendment deed---see mortgage document for full list of clauses and definitions.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 22 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold or leasehold property comprising the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; fixed charges over rights and claims, book debts and other debts; various assignments; floating charge over all other assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 28 giu 2000
    Consegnato il 15 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 ott 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 30 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 26 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 05 ott 1999
    Consegnato il 26 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgageopver property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley & Co International Limited
    Transazioni
    • 26 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 14 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Disposition & agreement
    Creato il 06 nov 1968
    Consegnato il 11 nov 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing the sum stated above
    Brevi particolari
    1,648 sq yds 8 sq feet plot of ground at ibrox, together with ibrox house erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • Board of Trade
    Transazioni
    • 11 nov 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Instrument of charge
    Creato il 22 ott 1968
    Consegnato il 04 nov 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all sums due or to become duebut not exceeding £10,000 of principal
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Board of Trade
    Transazioni
    • 04 nov 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0