KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC042425 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
- Agenti di commercio di legname e materiali da costruzione (46130) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 50 Mauchline Street G5 8HQ Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| KEYLINE BUILDERS MERCHANTS LIMITED | 30 gen 1991 | 30 gen 1991 |
| J. & W. HENDERSON LIMITED | 28 nov 1988 | 28 nov 1988 |
| CRH MERCHANTS LIMITED | 04 giu 1987 | 04 giu 1987 |
| CEMENT-ROADSTONE MERCHANTS LIMITED | 19 set 1986 | 19 set 1986 |
| WIMPEY MERCHANTS LIMITED | 21 lug 1965 | 21 lug 1965 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 giu 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 giu 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 01 giu 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Catherine Edwards come amministratore in data 31 gen 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Tpg Management Services Limited il 18 giu 2025 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Tp Directors Ltd il 18 giu 2025 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Travis Perkins Merchant Holdings Limited come persona con controllo significativo il 20 nov 2025 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Huw Russell Jenkins come amministratore in data 01 set 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Catherine Edwards il 23 lug 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 33 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Harris come amministratore in data 30 giu 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Robin Paul Miller come amministratore in data 28 gen 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Catherine Edwards come amministratore in data 28 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 02 dic 2024
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 32 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2024 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Dean Pinner come amministratore in data 31 mar 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Robin Paul Miller come amministratore in data 23 gen 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Alan Richard Williams come amministratore in data 23 gen 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 05 set 2023
| 6 pagine | SH02 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Richard Williams il 16 giu 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 38 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom |
| 186000060001 | ||||||||||
| ALCOCK, Thomas William | Amministratore | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom | United Kingdom | British | 156454570001 | |||||||||
| JENKINS, Huw Russell | Amministratore | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom | United Kingdom | British | 258399470001 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Amministratore | Ryehill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Arthur Joseph | Segretario | 63 Moorfoot Way Bearsden G61 4RL Glasgow | British | 604400002 | ||||||||||
| DOOHAN, John | Segretario | Trefoil Avenue G41 3PE Shawlands 48 Glasgow | British | 129812950001 | ||||||||||
| HOWLETT, Michael Robert | Segretario | 45 Kendal Close NN3 6WJ Northampton Northamptonshire | British | 12957700001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| SUTHERLAND, Andrew Campbell | Segretario | Fairways, 28 Gadloch Avenue Lenzie G66 5NP Glasgow | British | 86050600001 | ||||||||||
| ADAMS, Edward Cyril | Amministratore | Granville House Holly Farm Road Otham ME15 8RY Maidstone Kent | British | 14500800001 | ||||||||||
| AITKEN, John David | Amministratore | 26 Salisbury Road SP10 2JL Andover Hampshire | British | 717920001 | ||||||||||
| AITKEN, John David | Amministratore | 26 Salisbury Road SP10 2JL Andover Hampshire | British | 717920001 | ||||||||||
| BARRY, Anthony Dermot | Amministratore | Annamore 30 Sydney Avenue IRISH Blackrock Co Dublin | Irish | 717900001 | ||||||||||
| BELL, Norman | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 106766000001 | |||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Amministratore | 8 Strathkelvin Place G66 1XT Kirkintilloch Suite S3 Scotland Scotland | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CAHILL, Jack | Amministratore | 36 Netherblane Blanefield G63 9JW Glasgow | British | 37460910002 | ||||||||||
| CARTER, John Peter | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| CARTON, Maeve Catherine | Amministratore | 56 Mountain View Road Ranelagh IRISH Dublin 6 Ireland | Irish | 48332960001 | ||||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| DAVIDSON, Arthur Joseph | Amministratore | Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 604400004 | |||||||||
| DICKS, Christopher | Amministratore | 8 Strathkelvin Place G66 1XT Kirkintilloch Suite S3 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 203748470001 | |||||||||
| EDWARDS, Catherine | Amministratore | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom | England | British | 331745010001 | |||||||||
| ELKINS, Francis Mark | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 164172230002 | |||||||||
| GANDY, David | Amministratore | Malton Farm Malton Lane Meldreth SG8 6PE Royston Hertfordshire | British | 19322520001 | ||||||||||
| GODSON, Don | Amministratore | Island View Nerano Road IRISH Dalkey Co Durham Ireland | Irishsh | 42404310003 | ||||||||||
| GOLDSMITH, Ian Robert, Dr | Amministratore | Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | 70864590002 | ||||||||||
| GOUKA, Jacobus | Amministratore | Bosrand-38 3121 XA Schiedam Zuid Holland | Dutch | 48332710001 | ||||||||||
| GRIFFIN, Kieran | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 131159630001 | |||||||||
| GRIFFIN, William Gerard | Amministratore | Moonacre Killincarrig IRISH Delgany Co Wicklow Republic Of Ireland | Irish | 717160011 | ||||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HARRIS, Stephen | Amministratore | Mauchline Street G5 8HQ Glasgow 50 United Kingdom | England | British | 178050390001 | |||||||||
| HARRISON, Andrew Peter | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 246549720001 | |||||||||
| HILL, Brian Gerard | Amministratore | Ringdijk 14 3054 Kw FOREIGN Rotterdam The Netherlands | Irish | 63529150001 | ||||||||||
| HUGHES, Liam Patrick | Amministratore | 55 Southlea Road Datchet SL3 9BZ Slough Berkshire | Irish | 64295190001 | ||||||||||
| KAVANAGH, Carol | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 127248260001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Perkins Merchant Holdings Limited | 21 dic 2018 | Ryehill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Travis Perkins Plc | 06 apr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0