REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED

REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC044625
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor, Quay 2,
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    15 pagine4.26(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da * Gala Clubs Regional Office Kerse Lane Falkirk FK1 1RJ* in data 06 mar 2014

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mag 2013

    Stato del capitale al 30 mag 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Willits il 19 feb 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2010

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    7 pagineMG03s

    Cessazione della carica di Diane Penfold come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Harry Willits come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 set 2009

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Gala Coral Nominees Limited il 26 ott 2009

    1 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Diane June Penfold il 13 nov 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2008

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2007

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Segretario
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British149874460001
    HAMILTON, William Burt
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    Segretario
    Douglas House 58c Allanfauld Road
    Cumbernauld
    Glasgow
    British1054590001
    HODGES, Simon
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    Meadowbank 102 Crosshill Street
    Lennoxtown
    G66 7HQ Glasgow
    Lanarkshire
    British66090970001
    LANG, Anthony
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    British557550001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Segretario
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MAGEE, Martin Paul
    28 Barncluith Road
    ML3 7DQ Hamilton
    Lanarkshire
    Segretario
    28 Barncluith Road
    ML3 7DQ Hamilton
    Lanarkshire
    British1367560001
    MILLER, John Ashley Laing
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British97666900001
    MITCHELL, Andrew Ross
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    Segretario
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    British25359180002
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Segretario
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Amministratore
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Amministratore
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    GRIFFITHS, Jonathan
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    Amministratore
    11 Pageant Crescent
    SE16 5FZ London
    British73691620003
    JENKINS, Stuart Nicol
    Parkview, 7 Arden Drive
    Giffnock
    G46 7AF Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Parkview, 7 Arden Drive
    Giffnock
    G46 7AF Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116623260001
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Amministratore
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    MCCARVILL, James
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    Amministratore
    37 Brightside Avenue
    Uddingston
    G71 7NF Glasgow
    British24036030002
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MILLER, John Ashley Laing
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British97666900001
    O'CALLAGHAN, Francis
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Amministratore
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    ScotlandBritish557570001
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Amministratore
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    SCHOLARIOS, Fivos
    110 Haggs Road
    G41 4AT Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    110 Haggs Road
    G41 4AT Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish583820001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    STAKIS, Andros
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Amministratore
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    British27237990001
    STAKIS, Reo, Sir
    54 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HE Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    54 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HE Glasgow
    Lanarkshire
    British69301420001
    WAGGETT, Colin
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    Amministratore
    41 Spring Grove
    W4 3NH London
    British62266600001
    LADBROKE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    62360460001

    REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 11 mag 2006
    Consegnato il 26 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 03 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 16 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with any secured document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over property and assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 16 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 01 set 2005
    Consegnato il 20 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 20 set 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 23 ago 2005
    Consegnato il 05 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 set 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 24 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 10 feb 2005
    Consegnato il 16 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 17 mar 2003
    Consegnato il 21 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all real property in england and wales; first fixed equitable charge over all other real property; first fixed charge and first floating charge over assets.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston
    Transazioni
    • 21 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 13 mar 2003
    Consegnato il 27 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 21 dic 2000
    Consegnato il 10 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company
    Transazioni
    • 10 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 14 ago 1991
    Consegnato il 03 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Stakis PLC
    Transazioni
    • 03 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 14 ago 1991
    Consegnato il 03 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent of and Trustee for the Bank
    Transazioni
    • 03 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 28 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    REGENCY CASINO (GLASGOW) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 feb 2014Inizio della liquidazione
    11 ott 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0