MCCONNELL SALMON LIMITED

MCCONNELL SALMON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMCCONNELL SALMON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC045850
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MCCONNELL SALMON LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova MCCONNELL SALMON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Marine Harvest, Ratho Park
    88 Glasgow Road, Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Midlothian
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MCCONNELL SALMON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per MCCONNELL SALMON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 nov 2010

    Stato del capitale al 26 nov 2010

    • Capitale: GBP 5,185,000
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MCCONNELL SALMON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THOMPSON, Lorraine Elizabeth
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    British69247060001
    MCINTOSH, Kenneth James
    Colliers Way
    Whins Of Milton
    FK7 8FG Stirling
    10
    Stirlingshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Colliers Way
    Whins Of Milton
    FK7 8FG Stirling
    10
    Stirlingshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish124854160002
    SUTHERLAND, Alan George
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    Amministratore
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    ScotlandBritish121052220002
    ALEXANDER, Keith David Rennie
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    Segretario
    3 West Terrace
    High Street
    TN17 3LG Cranbrook
    Kent
    British35984770001
    MILLER, Andrew Charles
    Rydal Lodge
    1 Goldenfields Close
    GU30 7EZ Liphook
    Hampshire
    Segretario
    Rydal Lodge
    1 Goldenfields Close
    GU30 7EZ Liphook
    Hampshire
    British38236230002
    WILLETT, Peter Frederick
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    Segretario
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    British45112230002
    CAWLEY, John Andrew
    Redcote 23 Henry Bell Street
    G84 7HL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Redcote 23 Henry Bell Street
    G84 7HL Helensburgh
    Dunbartonshire
    British45899730001
    DAVIDSON, Donald Cameron Lamont
    191 Newhaven Road
    EH6 4QD Edinburgh
    Amministratore
    191 Newhaven Road
    EH6 4QD Edinburgh
    ScotlandBritish97047400001
    DEAR, Graeme, Dr
    16 William Place
    Scone
    PH2 6TF Perth
    Amministratore
    16 William Place
    Scone
    PH2 6TF Perth
    ScotlandBritish41516590002
    DEAR, Graeme
    6 Rowan Crescent
    Killearn
    G63 9RZ Glasgow
    Amministratore
    6 Rowan Crescent
    Killearn
    G63 9RZ Glasgow
    British41516590001
    DEN BIEMAN, Johannes Cornelius Antonius
    Anna Paulownalaan 48
    Nl-3818
    Ge Amersfoort
    The Netherlands
    Amministratore
    Anna Paulownalaan 48
    Nl-3818
    Ge Amersfoort
    The Netherlands
    NetherlandsDutch167379290002
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British2785880001
    GRAY, Paul Douglas
    1 Necton Road
    Wheathampstead
    AL4 8AT St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Necton Road
    Wheathampstead
    AL4 8AT St Albans
    Hertfordshire
    British55720410001
    GRONTVEDT, Havard Johannes
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Norwegian105815350001
    HOSKINS, Lowell
    299 Weed Street
    FOREIGN New Canaan
    Usa
    Amministratore
    299 Weed Street
    FOREIGN New Canaan
    Usa
    Usa12150001
    JOHNSON, Hugh Bernard
    30 Burnhead Road
    Cumbernauld
    G68 9BT Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    30 Burnhead Road
    Cumbernauld
    G68 9BT Glasgow
    Lanarkshire
    British12200002
    KUIJPERS, Johannes Theodorus
    De Driest 7
    3953 BS Maasbergen
    Utrecht
    The Netherlands
    Amministratore
    De Driest 7
    3953 BS Maasbergen
    Utrecht
    The Netherlands
    Dutch66052320001
    LISTER, John David
    Greystones Bonnington Road
    EH45 9HF Peebles
    Amministratore
    Greystones Bonnington Road
    EH45 9HF Peebles
    British1324750001
    MCCRONE, Iain Alastair
    Cardsknolls
    KY7 6LP Markinch
    Fife
    Amministratore
    Cardsknolls
    KY7 6LP Markinch
    Fife
    ScotlandBritish907970001
    MCCUNN, Archibald Eddington
    3 Mcintosh Way
    ML1 3BB Motherwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    3 Mcintosh Way
    ML1 3BB Motherwell
    Lanarkshire
    British263890001
    MILLER, Allan Gerard
    13 Birchwood Gardens
    Bellsquarry Village
    EH54 9JR Livingston
    Amministratore
    13 Birchwood Gardens
    Bellsquarry Village
    EH54 9JR Livingston
    ScotlandScottish84080100001
    NESTEL, Barry Lionel
    38 Hatchlands Road
    RH1 6AT Redhill
    Surrey
    Amministratore
    38 Hatchlands Road
    RH1 6AT Redhill
    Surrey
    British12160001
    NICOLSON, Malise Allen
    Frog Hall Tilston
    SY14 7HB Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    Frog Hall Tilston
    SY14 7HB Malpas
    Cheshire
    British12180001
    NORTHFIELD, Robin Derek
    42 Nelson Road
    SS6 8HB Rayleigh
    Essex
    Amministratore
    42 Nelson Road
    SS6 8HB Rayleigh
    Essex
    British12190001
    PARKER, Bruce Edwin
    Windham Road
    FOREIGN Marlborough
    Usa
    Amministratore
    Windham Road
    FOREIGN Marlborough
    Usa
    British1373860001
    ROBINSON, Edward Christopher
    142 Burbage Road
    SE21 7AG London
    Amministratore
    142 Burbage Road
    SE21 7AG London
    EnglandBritish12210001
    WILLETT, Peter Frederick
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    51 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    British45112230002
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Amministratore
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    ScotlandBritish84079420001
    WINDMILL, David Michael
    Priestfield Road North
    EH16 5HS Edinburgh
    2
    Amministratore
    Priestfield Road North
    EH16 5HS Edinburgh
    2
    ScotlandBritish82907910001

    MCCONNELL SALMON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Instrument of charge
    Creato il 10 feb 1976
    Consegnato il 24 feb 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20000
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Highlands & Islands Development Board
    Transazioni
    • 24 feb 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Instrument of charge
    Creato il 20 ott 1971
    Consegnato il 28 ott 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,500
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Highlands & Islands Development Board
    Transazioni
    • 28 ott 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Instrument of charge & agreement
    Creato il 31 dic 1968
    Consegnato il 13 gen 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,205
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Highlands & Islands Development Board
    Transazioni
    • 13 gen 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0