YERRUS NUMBER FIVE LIMITED

YERRUS NUMBER FIVE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYERRUS NUMBER FIVE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC046516
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    • fabbricazione di componenti elettronici (26110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit G4 Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Fife
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRESTWICK CIRCUITS LIMITED11 apr 196911 apr 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria

    4 pagine4.26(Scot)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di Sameet Vohra come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Shatish Dasani come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Shatish Damodar Dasani il 20 feb 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 gen 2012

    Stato del capitale al 30 gen 2012

    • Capitale: GBP 300,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Felbeck il 18 mag 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 1 Steadman Place Riverside Business Park Irvine Ayrshire KA11 5DN* in data 02 mar 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Felbeck il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Wendy Jill Sharp il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Wendy Jill Sharp il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Shatish Damodar Dasani il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    6 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di YERRUS NUMBER FIVE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHARP, Wendy Jill
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    Segretario
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    British129889700001
    FELBECK, Paul
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor69837530002
    SHARP, Wendy Jill
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary117318960001
    VOHRA, Sameet
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Clive House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    12-18 Queens Road
    KT13 9XB Weybridge
    Clive House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director126382440002
    FELBECK, Paul
    Flat E
    13 St Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Segretario
    Flat E
    13 St Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British69837530001
    HOGARTH, Morgan Matthew
    18 Ewenfield Avenue
    KA7 2QJ Ayr
    Segretario
    18 Ewenfield Avenue
    KA7 2QJ Ayr
    BritishChartered Accountant44152980001
    LEIGH, Martin Graham
    Cheriton 18 Paddock Way
    Woodham
    GU21 5TB Woking
    Surrey
    Segretario
    Cheriton 18 Paddock Way
    Woodham
    GU21 5TB Woking
    Surrey
    British2930710001
    MAIR, Thomas
    34 Golf Crescent
    KA10 6JZ Troon
    Ayrshire
    Segretario
    34 Golf Crescent
    KA10 6JZ Troon
    Ayrshire
    British234820001
    MCKIE, Robert Alastair
    14 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    Segretario
    14 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    British57973060001
    MILLIKEN, Kenneth
    24 Bathurst Drive
    Alloway
    KA7 4QN Ayr
    Ayrshire
    Segretario
    24 Bathurst Drive
    Alloway
    KA7 4QN Ayr
    Ayrshire
    British32763240001
    SHARP, Wendy Jill
    Hedges
    Jackmans Lane, St Johns
    GU21 7RL Woking
    Surrey
    Segretario
    Hedges
    Jackmans Lane, St Johns
    GU21 7RL Woking
    Surrey
    BritishCompany Secretary117318960001
    ATKINS, Martin Ronald
    8 Ivetsey Close
    ST19 9QR Wheaton Aston
    Staffordshire
    Amministratore
    8 Ivetsey Close
    ST19 9QR Wheaton Aston
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector83456180001
    BARLOW, Paul Stephen, Dr
    46 Park Circus
    KA7 2DL Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    46 Park Circus
    KA7 2DL Ayr
    Ayrshire
    BritishExecutive Director54884890004
    BLAIR, David
    Burlington Manor
    Jubilee Road
    RG40 3SD Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    Burlington Manor
    Jubilee Road
    RG40 3SD Finchampstead
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director71195900001
    BROWN, Philip Gordon
    8 Homefield Road
    BN11 2HZ Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    8 Homefield Road
    BN11 2HZ Worthing
    West Sussex
    EnglandBritishManager39885680002
    CARMICHAEL, Peter John, Dr
    16 Mansfield Road
    KA9 2DL Prestwick
    Amministratore
    16 Mansfield Road
    KA9 2DL Prestwick
    ScotlandBritishCompany Director108347060001
    CLARKE, Thomas Maxwell
    Highview
    KA19 8 Maybole
    Ayrshire
    Amministratore
    Highview
    KA19 8 Maybole
    Ayrshire
    BritishCompany Director234840001
    COULSON, Francis Archer
    West Dullater
    FK17 8HG Callander
    Perthshire
    Amministratore
    West Dullater
    FK17 8HG Callander
    Perthshire
    United KingdomBritishCompany Director56397070001
    CREANEY, Samuel Thomas
    107 Belfast Road
    BT66 7JU Lurgan
    County Armagh
    Amministratore
    107 Belfast Road
    BT66 7JU Lurgan
    County Armagh
    BritishCompany Director53991110001
    DASANI, Shatish Damodar
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    Telford Road
    Eastfield Industrial Estate
    KY7 4NX Glenrothes
    Unit G4
    Fife
    United Kingdom
    EnglandBritish132555670003
    DAVIES, Graham
    Apple Tree Cottage
    13 Field Lane Cam
    GL11 6JF Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Apple Tree Cottage
    13 Field Lane Cam
    GL11 6JF Dursley
    Gloucestershire
    BritishManaging Director45162660003
    HOGARTH, Morgan Matthew
    18 Ewenfield Avenue
    KA7 2QJ Ayr
    Amministratore
    18 Ewenfield Avenue
    KA7 2QJ Ayr
    Great BritainBritishChartered Accountant44152980001
    ISMAIL, Ismail
    4 Gryfewood Crescent
    PA6 7LY Houston
    Renfrewshire
    Amministratore
    4 Gryfewood Crescent
    PA6 7LY Houston
    Renfrewshire
    BritishMaterials Director99751790001
    MACMILLAN, Roger George
    11 Bellrock Avenue
    KA9 1SQ Prestwick
    Amministratore
    11 Bellrock Avenue
    KA9 1SQ Prestwick
    BritishAccountant77506830001
    MAIR, Thomas
    34 Golf Crescent
    KA10 6JZ Troon
    Ayrshire
    Amministratore
    34 Golf Crescent
    KA10 6JZ Troon
    Ayrshire
    BritishPersonnel Director234820001
    MANSFIELD, Derek Steven
    5 Bentfield Drive
    KA9 1TT Prestwick
    Ayrshire
    Amministratore
    5 Bentfield Drive
    KA9 1TT Prestwick
    Ayrshire
    BritishManaging Director81405360002
    MCCALLUM, Peter
    37 High Park Road
    KA6 6QL Coylton
    Ayrshire
    Amministratore
    37 High Park Road
    KA6 6QL Coylton
    Ayrshire
    BritishOperations Director81405470004
    MCDONALD, James Fraser
    Macharin
    2 Chapelhill Cottage
    KA22 7NS Ardrossan
    Amministratore
    Macharin
    2 Chapelhill Cottage
    KA22 7NS Ardrossan
    ScotlandBritishManufacturing Director73708240002
    MCKEE, Martin Jack
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    Amministratore
    24 Worsley Crescent
    Newton Mearns
    G77 6DW Glasgow
    ScotlandBritishFinance Director41647290001
    MCKENZIE, Douglas Charles
    3 Doonholm Road
    Alloway
    KA7 4QQ Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    3 Doonholm Road
    Alloway
    KA7 4QQ Ayr
    Ayrshire
    BritishCompany Director48853570001
    MCKIE, Robert Alastair
    14 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    Amministratore
    14 Doonholm Road
    KA7 4QQ Alloway
    Ayrshire
    BritishChartered Accountant57973060001
    MCMILLAN, Ronald
    12 Lexwell Avenue
    Elderslie
    PA5 9AF Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    12 Lexwell Avenue
    Elderslie
    PA5 9AF Johnstone
    Renfrewshire
    BritishCompany Director893380001
    MILLER, William Brown
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director30221770001
    MOORE, Patrick William Henry
    2 Collingwood Mansions
    NE29 6HA North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    2 Collingwood Mansions
    NE29 6HA North Shields
    Tyne & Wear
    BritishDirector45671940004
    OSMAN, Wayne Miles
    48a Queens Road
    SG13 8BB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    48a Queens Road
    SG13 8BB Hertford
    Hertfordshire
    British37925180001

    YERRUS NUMBER FIVE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 31 gen 1997
    Consegnato il 07 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 apr 1997Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 05 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 17 ago 1994
    Consegnato il 25 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 apr 1997Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 23 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 07 ott 1993
    Consegnato il 13 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Factory unit known as block one, mosshill industrial estate, by ayr.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 27 giu 1977
    Consegnato il 30 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 20 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    YERRUS NUMBER FIVE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 nov 2014Data di scioglimento
    25 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Tim Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Notescottish-insolvency-info

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0