MILLER HOMES TWO LIMITED

MILLER HOMES TWO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILLER HOMES TWO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC046907
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILLER HOMES TWO LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova MILLER HOMES TWO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MILLER HOMES TWO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILLER HOMES LIMITED09 giu 198609 giu 1986
    MILLER HOMES NORTHERN LIMITED18 set 196918 set 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILLER HOMES TWO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per MILLER HOMES TWO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Julie Mansfield Jackson il 25 giu 2024

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Garry Mcdonald come amministratore in data 12 ott 2023

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Christopher John Endsor come amministratore in data 25 gen 2023

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2016

    Stato del capitale al 13 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Murdoch il 03 ago 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di MILLER HOMES TWO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Julie Mansfield
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish94193070002
    MURDOCH, Ian
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish179717450001
    BRAND, William Joseph
    1 Wardie Dell
    EH5 1AE Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    1 Wardie Dell
    EH5 1AE Edinburgh
    Midlothian
    British325070001
    DONALDSON, Euan James
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    28 Trainers Brae
    EH39 4NR North Berwick
    East Lothian
    British41273760002
    LAWSON, Gordon Kenneth
    5 Trench Knowe
    EH10 7HL Edinburgh
    Segretario
    5 Trench Knowe
    EH10 7HL Edinburgh
    British145330001
    MACKINNON, Iain Lachlan
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    Segretario
    1 Hermitage Drive
    EH10 6DE Edinburgh
    British66282570001
    SMYTH, Pamela June
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Segretario
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    British65057960002
    ANDERSON, Ewan Thomas
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish71536430001
    BELL, Darren
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Amministratore
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    United KingdomBritish73256080001
    BENSON, Deborah Clare
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    British52845300004
    BENSON, Deborah Clare
    36 Reid Terrace
    EH3 5JH Edinburgh
    Amministratore
    36 Reid Terrace
    EH3 5JH Edinburgh
    British52845300003
    BROGAN, Peter
    21 Dryburn Brae
    EH46 7JG West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    21 Dryburn Brae
    EH46 7JG West Linton
    Peeblesshire
    ScotlandBritish52845290002
    COLEBROOK, Peter
    Commonside
    Crowle
    DN17 4EY Doncaster
    Hope House
    S Yorkshire
    Amministratore
    Commonside
    Crowle
    DN17 4EY Doncaster
    Hope House
    S Yorkshire
    United KingdomBritish132648180001
    DOWNING, Martin Richard Frederick
    6 Stamford Croft
    B91 3FS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    6 Stamford Croft
    B91 3FS Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish37584690003
    ENDSOR, Christopher John
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish86411120001
    FERMOR-DUNMAN, Geoffrey
    6 The Orchards
    Orton Waterville
    PE2 5LA Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    6 The Orchards
    Orton Waterville
    PE2 5LA Peterborough
    Cambridgeshire
    British42775270001
    GAFFNEY, David
    11 Doonfoot Gardens
    G74 4XF East Kilbride
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Doonfoot Gardens
    G74 4XF East Kilbride
    Lanarkshire
    ScotlandBritish84605410001
    HAY, Robert William
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Torrells Pursers Lane
    Peaslake
    GU5 9RE Guildford
    Surrey
    British53354130002
    HEAD, Alan William
    Park House
    Baconsmead, Denham Village
    UB9 5AY Uxbridge
    Bucks
    Amministratore
    Park House
    Baconsmead, Denham Village
    UB9 5AY Uxbridge
    Bucks
    United KingdomBritish111262610001
    HOGG, Philip John
    44 Eastfield
    EH15 2PN Edinburgh
    Amministratore
    44 Eastfield
    EH15 2PN Edinburgh
    British66410240002
    HOUGH, Timothy
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    EnglandBritish80381140002
    JACOBS, Ronnie Alexander
    3 Avonmill Road
    Linlithgow Bridge
    EH49 7SQ Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    3 Avonmill Road
    Linlithgow Bridge
    EH49 7SQ Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritish48274930001
    LEWIS, Donald Rhys
    Pine Cottage
    Beech Hill
    EH41 4PE Gifford
    East Lothian
    Amministratore
    Pine Cottage
    Beech Hill
    EH41 4PE Gifford
    East Lothian
    British9221980002
    LIGHT, Brian
    64 Williams Park
    Benton
    NE12 8BL Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    64 Williams Park
    Benton
    NE12 8BL Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British81432410001
    MCCOLL, Iain Alistair
    11 Forth Road
    Torrance
    G64 4EB Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Forth Road
    Torrance
    G64 4EB Glasgow
    Lanarkshire
    British502500001
    MCDONALD, Garry
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    United KingdomBritish89831670003
    MILLAR, Robert Brandon
    5 Craiglea Place
    EH10 5QA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Craiglea Place
    EH10 5QA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish52845370001
    MILLER, Keith Manson
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Amministratore
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritish546650002
    MILLER, Roger Ogilvy Stewart
    17 Belgrave Crescent
    EH4 3AJ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    17 Belgrave Crescent
    EH4 3AJ Edinburgh
    Midlothian
    British145350001
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    British573140004
    MILSON, Arthur
    33 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    33 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish99618160001
    MITCHELL, William Ian
    14 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    14 Belgrave Crescent
    EH4 3AH Edinburgh
    Midlothian
    British491700001
    O'DONNELL, Harry Joseph
    30 Alder Road
    G43 2UU Glasgow
    Amministratore
    30 Alder Road
    G43 2UU Glasgow
    United KingdomBritish46524710001
    O'DONNELL, Harry Joseph
    30 Alder Road
    G43 2UU Glasgow
    Amministratore
    30 Alder Road
    G43 2UU Glasgow
    United KingdomBritish46524710001
    PARRETT, Keith Joseph
    16 Carpenders Close
    AL5 3HN Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    16 Carpenders Close
    AL5 3HN Harpenden
    Hertfordshire
    British12477930001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MILLER HOMES TWO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    2 Lochside View
    Edinburgh Park
    EH12 9DH Edinburgh
    Miller House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    2 Lochside View
    Edinburgh Park
    EH12 9DH Edinburgh
    Miller House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc255430
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MILLER HOMES TWO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 16 apr 1999
    Consegnato il 26 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £184,800
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 2.91 acres at ambleside terrace, dundee.
    Persone aventi diritto
    • Barratt Homes Limited
    Transazioni
    • 26 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 mag 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 17 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 18 gen 1999
    Consegnato il 22 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at kendoon avenue,drumchapel,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 22 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 27 nov 1998
    Consegnato il 04 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £685,200
    Brevi particolari
    2 plots at moredun road,paisley.
    Persone aventi diritto
    • The Renfrewshire Council
    Transazioni
    • 04 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 19 gen 1998
    Consegnato il 27 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.64 hectares at the north western end of leader street,riddrie,lanark.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 27 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 27 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 lug 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Coatbridge health studios,sunnyside road,coatbridge.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Homes
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 19 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 27 mag 1996
    Consegnato il 12 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Valleyfield road,penicuik.
    Persone aventi diritto
    • Urbanleague Limited
    Transazioni
    • 12 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 27 mag 1996
    Consegnato il 06 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects lying to the north east of the present terminus of valleyfield road, penicuik.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Enterprise
    Transazioni
    • 06 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 02 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 06 nov 1995
    Consegnato il 16 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All further sums due or to become due not exceeding £70000
    Brevi particolari
    All and whoel that plot or area of ground extending to 0.49 hectares of thereby netric measure situated at bulloch crescent, denny in the county of stirling being the generally south portion of the subjects registered in the land register of scotland under title no stg 13506.
    Persone aventi diritto
    • Falkirk District Council
    Transazioni
    • 16 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 23 ago 1995
    Consegnato il 29 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £120,000
    Brevi particolari
    124 west king street, helensburgh, registered under title number dmb 31915.
    Persone aventi diritto
    • The Firm of Angus N. Macinnes
    Transazioni
    • 29 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 23 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 22 mag 1995
    Consegnato il 05 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    19.69 acres in the county of midlothian lying to the south east of the A701 public road.
    Persone aventi diritto
    • Straiton Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 apr 1993
    Consegnato il 20 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    30 stewartfield, east kilbride.
    Persone aventi diritto
    • East Kilbride Development Corporation
    Transazioni
    • 20 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 26 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 set 1991
    Consegnato il 11 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £970,000
    Brevi particolari
    Five areas at moorfoot avenue, paisley.
    Persone aventi diritto
    • The District Council of Renfrew
    Transazioni
    • 11 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 15 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 31 lug 1991
    Consegnato il 15 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.05 hectares within clydebank,dumbarton.
    Persone aventi diritto
    • Scottish Enterprise
    Transazioni
    • 15 ago 1991Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 20 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0