MILLER HOMES TWO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MILLER HOMES TWO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC046907 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MILLER HOMES TWO LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova MILLER HOMES TWO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MILLER HOMES TWO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MILLER HOMES LIMITED | 09 giu 1986 | 09 giu 1986 |
| MILLER HOMES NORTHERN LIMITED | 18 set 1969 | 18 set 1969 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MILLER HOMES TWO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per MILLER HOMES TWO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Julie Mansfield Jackson il 25 giu 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Garry Mcdonald come amministratore in data 12 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John Endsor come amministratore in data 25 gen 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Murdoch il 03 ago 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MILLER HOMES TWO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, Julie Mansfield | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 94193070002 | |||||
| MURDOCH, Ian | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 179717450001 | |||||
| BRAND, William Joseph | Segretario | 1 Wardie Dell EH5 1AE Edinburgh Midlothian | British | 325070001 | ||||||
| DONALDSON, Euan James | Segretario | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||
| LAWSON, Gordon Kenneth | Segretario | 5 Trench Knowe EH10 7HL Edinburgh | British | 145330001 | ||||||
| MACKINNON, Iain Lachlan | Segretario | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Segretario | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| ANDERSON, Ewan Thomas | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 71536430001 | |||||
| BELL, Darren | Amministratore | 5 Brookway Wrea Green PR4 2NU Preston | United Kingdom | British | 73256080001 | |||||
| BENSON, Deborah Clare | Amministratore | 30 Wardie Square EH5 1EU Edinburgh Lothian | British | 52845300004 | ||||||
| BENSON, Deborah Clare | Amministratore | 36 Reid Terrace EH3 5JH Edinburgh | British | 52845300003 | ||||||
| BROGAN, Peter | Amministratore | 21 Dryburn Brae EH46 7JG West Linton Peeblesshire | Scotland | British | 52845290002 | |||||
| COLEBROOK, Peter | Amministratore | Commonside Crowle DN17 4EY Doncaster Hope House S Yorkshire | United Kingdom | British | 132648180001 | |||||
| DOWNING, Martin Richard Frederick | Amministratore | 6 Stamford Croft B91 3FS Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 37584690003 | |||||
| ENDSOR, Christopher John | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 86411120001 | |||||
| FERMOR-DUNMAN, Geoffrey | Amministratore | 6 The Orchards Orton Waterville PE2 5LA Peterborough Cambridgeshire | British | 42775270001 | ||||||
| GAFFNEY, David | Amministratore | 11 Doonfoot Gardens G74 4XF East Kilbride Lanarkshire | Scotland | British | 84605410001 | |||||
| HAY, Robert William | Amministratore | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | British | 53354130002 | ||||||
| HEAD, Alan William | Amministratore | Park House Baconsmead, Denham Village UB9 5AY Uxbridge Bucks | United Kingdom | British | 111262610001 | |||||
| HOGG, Philip John | Amministratore | 44 Eastfield EH15 2PN Edinburgh | British | 66410240002 | ||||||
| HOUGH, Timothy | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | England | British | 80381140002 | |||||
| JACOBS, Ronnie Alexander | Amministratore | 3 Avonmill Road Linlithgow Bridge EH49 7SQ Linlithgow West Lothian | Scotland | British | 48274930001 | |||||
| LEWIS, Donald Rhys | Amministratore | Pine Cottage Beech Hill EH41 4PE Gifford East Lothian | British | 9221980002 | ||||||
| LIGHT, Brian | Amministratore | 64 Williams Park Benton NE12 8BL Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 81432410001 | ||||||
| MCCOLL, Iain Alistair | Amministratore | 11 Forth Road Torrance G64 4EB Glasgow Lanarkshire | British | 502500001 | ||||||
| MCDONALD, Garry | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 89831670003 | |||||
| MILLAR, Robert Brandon | Amministratore | 5 Craiglea Place EH10 5QA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 52845370001 | |||||
| MILLER, Keith Manson | Amministratore | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 546650002 | |||||
| MILLER, Roger Ogilvy Stewart | Amministratore | 17 Belgrave Crescent EH4 3AJ Edinburgh Midlothian | British | 145350001 | ||||||
| MILLS, Stanley | Amministratore | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | 573140004 | ||||||
| MILSON, Arthur | Amministratore | 33 The Steils EH10 5XD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 99618160001 | |||||
| MITCHELL, William Ian | Amministratore | 14 Belgrave Crescent EH4 3AH Edinburgh Midlothian | British | 491700001 | ||||||
| O'DONNELL, Harry Joseph | Amministratore | 30 Alder Road G43 2UU Glasgow | United Kingdom | British | 46524710001 | |||||
| O'DONNELL, Harry Joseph | Amministratore | 30 Alder Road G43 2UU Glasgow | United Kingdom | British | 46524710001 | |||||
| PARRETT, Keith Joseph | Amministratore | 16 Carpenders Close AL5 3HN Harpenden Hertfordshire | British | 12477930001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MILLER HOMES TWO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller Homes Holdings Limited | 06 apr 2016 | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MILLER HOMES TWO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 16 apr 1999 Consegnato il 26 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £184,800 | |
Brevi particolari Area of ground extending to 2.91 acres at ambleside terrace, dundee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 18 gen 1999 Consegnato il 22 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Land at kendoon avenue,drumchapel,glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 27 nov 1998 Consegnato il 04 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £685,200 | |
Brevi particolari 2 plots at moredun road,paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 19 gen 1998 Consegnato il 27 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1.64 hectares at the north western end of leader street,riddrie,lanark. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 04 lug 1996 Consegnato il 16 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Coatbridge health studios,sunnyside road,coatbridge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 27 mag 1996 Consegnato il 12 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Valleyfield road,penicuik. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 27 mag 1996 Consegnato il 06 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Subjects lying to the north east of the present terminus of valleyfield road, penicuik. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 06 nov 1995 Consegnato il 16 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All further sums due or to become due not exceeding £70000 | |
Brevi particolari All and whoel that plot or area of ground extending to 0.49 hectares of thereby netric measure situated at bulloch crescent, denny in the county of stirling being the generally south portion of the subjects registered in the land register of scotland under title no stg 13506. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 23 ago 1995 Consegnato il 29 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £120,000 | |
Brevi particolari 124 west king street, helensburgh, registered under title number dmb 31915. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 22 mag 1995 Consegnato il 05 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 19.69 acres in the county of midlothian lying to the south east of the A701 public road. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 06 apr 1993 Consegnato il 20 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 30 stewartfield, east kilbride. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 30 set 1991 Consegnato il 11 ott 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £970,000 | |
Brevi particolari Five areas at moorfoot avenue, paisley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 31 lug 1991 Consegnato il 15 ago 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 2.05 hectares within clydebank,dumbarton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0