GLADEDALE CAPITAL LIMITED

GLADEDALE CAPITAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLADEDALE CAPITAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC048050
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLADEDALE CAPITAL LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova GLADEDALE CAPITAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE CAPITAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BETT PROPERTIES LIMITED16 giu 198816 giu 1988
    BETT BROTHERS (PROPERTIES) LIMITED30 ott 197030 ott 1970

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE CAPITAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE CAPITAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    2 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2016

    Stato del capitale al 27 giu 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di David Jonathan Knight come amministratore in data 27 giu 2016

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr David Jonathan Knight come amministratore in data 11 mar 2016

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2015 al 30 apr 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Henry Sharp il 22 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Joanne Elizabeth Massey il 22 ott 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG a Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT in data 23 ott 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mar 2015

    Stato del capitale al 12 mar 2015

    • Capitale: GBP 14,532,678
    SH01

    Nomina di Mr Giles Sharp come amministratore in data 23 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Fitzsimmons come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di GLADEDALE CAPITAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Segretario
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809170001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    BYRNE, Rosemary
    7/2 Admiralty Street
    EH6 6JT Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    7/2 Admiralty Street
    EH6 6JT Edinburgh
    Midlothian
    British108647330001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    MILLIGAN, Michael
    3 Haining Valley Steading
    EH49 6LN Linlithgow
    West Lothian
    Segretario
    3 Haining Valley Steading
    EH49 6LN Linlithgow
    West Lothian
    British122258600001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Amministratore
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    BETT, Stewart
    4 Pitempton Road
    Downfield
    DD3 9EJ Dundee
    Angus
    Amministratore
    4 Pitempton Road
    Downfield
    DD3 9EJ Dundee
    Angus
    British175330001
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Amministratore
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CURRAN, Paul
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Amministratore
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    ScotlandBritish110978610002
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    Amministratore
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    ScotlandBritish110978610002
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    50 Warlington Road
    CR7 7DE Thornton Heath
    Surrey
    Amministratore
    50 Warlington Road
    CR7 7DE Thornton Heath
    Surrey
    British75350600001
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Amministratore
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GORE, Derek Cyril
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    Amministratore
    15 Rockfield Crescent
    DD2 1JF Dundee
    Tayside
    British92043160001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    KNIGHT, David Jonathan
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Amministratore
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish190746580001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MACPHERSON, Colin
    Mair End
    EH32 OUG Aberlady
    3
    East Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Mair End
    EH32 OUG Aberlady
    3
    East Lothian
    Scotland
    British111491910002
    MCINTYRE, James
    2 Whinny View
    EH32 0UJ Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    2 Whinny View
    EH32 0UJ Aberlady
    East Lothian
    British108647410001
    MILLIGAN, Michael
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Amministratore
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    ScotlandBritish153845120001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Amministratore
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    ROBINSON, David
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    ScotlandUnited Kingdom50541770001
    SMITH, Martin James Alexander
    76 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    76 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish116879890001
    TOWNSEND, Ian Trye
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    Amministratore
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    United KingdomBritish320150001
    WEBSTER, Graham Hodge
    High Williamshaw House
    Old Glasgow Road
    KA3 5JR Stewarton
    Ayrshire
    Amministratore
    High Williamshaw House
    Old Glasgow Road
    KA3 5JR Stewarton
    Ayrshire
    ScotlandBritish71280002

    GLADEDALE CAPITAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 05 nov 2010
    Consegnato il 12 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In terms of the missives
    Brevi particolari
    Five acres part of the estate of balgillo broughty ferry dundee situated on the north side of arbroath road and known as claypotts nursery arbroath road dundee.
    Persone aventi diritto
    • Hedges Development Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01s)
    • 04 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Security agreement
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 16 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 30 set 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Shares pledge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1 ordinary share in quartermile estates limited.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 01 set 2009
    Consegnato il 15 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 30 set 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Westburn foundry, arbroath.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    7 & 11 carrick street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    222 broomielaw, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 27 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    9 carrick street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 mag 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 04 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    19-29 carrick street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    40 mcalpine street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    33/37 carrick street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Standard security
    Creato il 19 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    39 carrick street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 04 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02s)
    Legal charge
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 26 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over freehold land & buildings forming part of tyne tunnel trading estate, tynemouth TY106211.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 16 feb 2007
    Consegnato il 27 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Westhill shopping centre, old skene road, aberdeen ABN40318.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 05 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 07 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground on east side of maconochie road, fraserburgh ABN60332.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 15 mar 2004
    Consegnato il 16 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    0.707 acres at lochavullin road, oban.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 21 mag 2003
    Consegnato il 03 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Floating charge
    Creato il 20 mag 2003
    Consegnato il 28 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the properties--title number HW181742 being land lying to the north of buntsford hill; title number WR46514 being land lying to the north east of buntsford hill, bromsgrove; title number WR51222 being land to the north east side of buntsford hill; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 set 2009Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 16 lug 2012Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 07 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 13 apr 1995
    Consegnato il 27 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Option to purchase the reversionary heritable interest of the subjects let in a long lease
    Brevi particolari
    Heritable title of 1.52 hectares or thereby in dundee technology park dundee.
    Persone aventi diritto
    • Empson Road Limited
    Transazioni
    • 27 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 03 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 08 ott 1992
    Consegnato il 19 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 29 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 nov 1990
    Consegnato il 13 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground on the west side of market street, victoria tower and any fixture and fittings therein and thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 dic 1989
    Consegnato il 22 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by the company and another
    Brevi particolari
    Victoria tower market street aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 lug 1987
    Consegnato il 04 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plot of ground in dundee extending to one hectare and 52 decimal.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0