SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.

SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC049239
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    • Altra vendita al dettaglio di nuovi beni in negozi specializzati (non gallerie d'arte commerciali e ottici) (47789) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SALON SERVICES (HAIRDRESSING SUPPLIES) LIMITED27 set 197127 set 1971

    Quali sono gli ultimi bilanci di SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2021

    10 pagineAA

    Stato del capitale al 12 apr 2022

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    £2,460,344 standing to the credit of the company's capital contribution reserve capitalised to sally uk holdngs LTD 26/01/2022
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 gen 2022

    • Capitale: GBP 2,465,344
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Nina Azemoudeh come segretario in data 13 nov 2019

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Sarah Finch come amministratore in data 30 mar 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Heidi Van Ocken come amministratore in data 23 mar 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Olivier Badezet come amministratore in data 23 mar 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Sally Uk Holdings Limited come persona con controllo significativo il 07 feb 2018

    2 paginePSC05

    Chi sono gli amministratori di SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BADEZET, Olivier
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    FranceFrench245094380001
    SCARR, Warren Peter
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    EnglandBritish187830740001
    VAN OCKEN, Heidi
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    BelgiumBelgian245092140001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Segretario
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    British610080001
    AZEMOUDEH, Nina
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Segretario
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    British148931910001
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British76739920001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Amministratore
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    ScotlandBritish610080001
    BURNS, Margaret Bell
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Amministratore
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Scotland, UkBritish55852770003
    CONNOLLY, Michael John
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    Amministratore
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117746340001
    DEWEY, Michael John
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    UkAmerican199356850001
    DIAMOND, Robin C
    Glavecottage, 41 Spa Road
    BT24 8PT Ballynahinch
    Co.Down
    Amministratore
    Glavecottage, 41 Spa Road
    BT24 8PT Ballynahinch
    Co.Down
    British610710006
    FAULKNER, Mark
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    UsaAmerican136766440001
    FINCH, Joanne Sarah
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Amministratore
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    HEGARTY, Gerard P
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    Amministratore
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    ScotlandBritish610090002
    HEGARTY, Maureen
    Glen Imm
    Alloway
    Ayrshire
    Scotland
    Amministratore
    Glen Imm
    Alloway
    Ayrshire
    Scotland
    British17646720001
    HULL, Richard George
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish108758410001
    MACDONOUGH, Gordon S
    Nethermill Drumore Road
    Killearn
    G63 9NX Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Nethermill Drumore Road
    Killearn
    G63 9NX Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish610120003
    NICHOLSON, Alistair
    1a Bellvue Road
    Kirkintilloch
    Glasgow
    Amministratore
    1a Bellvue Road
    Kirkintilloch
    Glasgow
    British610690007
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish76739920001
    PECKHAM, Stephen
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    Uk
    Amministratore
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    Uk
    EnglandBritish69764870003
    POSTON, John
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    Amministratore
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    American97966830002
    WINTERHALTER, Gary Gene
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    Amministratore
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    American113530080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sally Uk Holdings Limited
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Inspired, Ground Floor
    Berkshire
    England
    06 apr 2016
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Inspired, Ground Floor
    Berkshire
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies
    Numero di registrazione05836805
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 30 gen 2004
    Consegnato il 16 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease over block 7, evanton drive, thornliebank industrial estate, glasgow GLA124713 GLA15264.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 giu 1990
    Consegnato il 02 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plot 69 (flat 83/8) lancefield quay glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 apr 1989
    Consegnato il 20 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    2.37 acres at hillington industrial estate, glasgow (82/90 kelvin avenue, hillington).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 gen 1989
    Consegnato il 23 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The dome, 66/74 broomielaw glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 apr 1988
    Consegnato il 14 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground lying north of broomielaw containing 197 square yards and 5 square feet.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 feb 1988
    Consegnato il 22 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    5-9 oswald street, glasgow 3-9 oswald street, glasgow 54-62 broomielaw, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 feb 1986
    Consegnato il 27 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    29/31/33/35 bridge st, glasgow 151/153/155 oxford st, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1984
    Consegnato il 12 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease 12A cloisters court see page 2 doc 51.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 15 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 set 1981
    Consegnato il 25 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects north east of said subjects.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 07 set 1981
    Consegnato il 25 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    134 to 150 broomielaw, 4 to 12 james watt street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 1982Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 23 nov 1976
    Consegnato il 01 dic 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 dic 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Gr. Midlothian standard security
    Creato il 12 nov 1975
    Consegnato il 20 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground floor & basement premises known as 50/52 bernard st. Leith, in the city of edinburgh & county of midlothian.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0