RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRUBY DCO TWENTY TWO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC053733
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KYLE AND CARRICK HOLDINGS LIMITED01 ago 197301 ago 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Ruby Dco Twenty One Limited come persona con controllo significativo il 18 set 2023

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Ayrshire Pharmaceuticals Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2023

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland a Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP in data 18 set 2023

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Graham Wiseman come amministratore in data 31 ago 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Thorsten Sprank come amministratore in data 31 ago 2023

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed kyle and carrick holdings LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 set 2023

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 ago 2023

    RES15

    Stato del capitale al 15 ago 2023

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 gen 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Wendy Margaret Hall come amministratore in data 09 set 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nichola Louise Legg come segretario in data 09 set 2022

    1 pagineTM02

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Memorandum e Statuto

    33 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Removal of restriction on authorised share capital/ ratification of directors actions 07/09/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Graham Wiseman come amministratore in data 07 set 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 18 mag 2022

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPRANK, Thorsten
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Amministratore
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGermanAccountant203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Segretario
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    GILMOUR, David Strachan
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    Segretario
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    British52130850001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    RAINEY, Gary
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    Segretario
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    British3535890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Segretario
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGermanCfo172030260001
    COCKBURN, Henry James Kemp
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    BritishPharmacist504660001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director118296490001
    GILBERT, George Andrew
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    Amministratore
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    BritishPharmacist469190001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishSolicitor172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGermanFinance Director238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    BritishFinancial Director39644740002
    JOHNSTONE, Ian James
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishPharmacist58656120002
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Amministratore
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritishChief Finance Officer54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritishGroup Human Resources Director8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGermanFinance Director220582440001
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    BritishCompany Director2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director35546210001
    MCCONNELL, Walter Scott
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    Amministratore
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    BritishPharmacist469160001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissDirector43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GermanyChief Finance Officer62107000001
    PRINGLE, John Stock
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    Amministratore
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    BritishPharmacist355710003
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    BritishPharmacist88210002
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    BritishPharmacist88210002
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritishSolicitor162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishCompany Secretary16898700002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Amministratore
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director1415570001
    TAYLOR, Andrew James
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    Amministratore
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    BritishPharmacist29348070001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    BritishCompany Director51796560002

    Chi sono le persone con controllo significativo di RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06 apr 2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc040149
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 04 mag 1990
    Consegnato il 14 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Long lease of shop 178 main street auchinleck, ayrshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 mag 1990
    Consegnato il 14 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    27 townhead street cumnock, ayr.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 mag 1990
    Consegnato il 14 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop at 67-73 high street, maybole ayrshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 13 apr 1990
    Consegnato il 02 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    123/129 high st lanark 116/118 north vennel lanark.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 feb 1990
    Consegnato il 14 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    64 mid street bathgate.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 12 ott 1989
    Consegnato il 20 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 4 & 4A glasgow road burnbank glasgow lan 57118.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 10 mar 1987
    Consegnato il 19 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    268 glasgow rd blantyre.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 nov 1986
    Consegnato il 04 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    (1) 270/272 glasgow road, blantyre (2) one up left 4 joanna terrace, blantyre one up right 4 joanna terrace blantyre regd title no lan 20237.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 mag 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises at 48 hanover street stranraer wigtownshire.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 02 mag 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises at 19 the foregate kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 mag 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises at 33 burnbank road, hamilton.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 mag 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises at 57 portland place hamilton.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 02 mag 1984
    Consegnato il 10 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tennents interest in lease of shop premises known as 15 burnbank centre glasgow rd burnbank.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 22 mar 1984
    Consegnato il 28 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0