BREDERO HOMES LIMITED

BREDERO HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBREDERO HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC055391
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BREDERO HOMES LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova BREDERO HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BREDERO HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BREDERO HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    legacy

    3 pagineMG03s

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 16 mar 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ in data 02 feb 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin Johnson come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Joanne Elizabeth Massey come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del segretario cambiati per Robin Simon Johnson il 24 nov 2009

    1 pagineCH03

    Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 13 nov 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    35 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Group specific conflicts 01/09/2009
    RES13

    Chi sono gli amministratori di BREDERO HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809050001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    BADCOCK, Peter Colin
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    British545530001
    BANERJEE, Pradip
    4 Seaton Stables
    AB2 1XS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    4 Seaton Stables
    AB2 1XS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British756560001
    FACER, John Leslie
    29 Bovingdon Green
    Bovingdon
    HP3 0LB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    29 Bovingdon Green
    Bovingdon
    HP3 0LB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British33795700001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    KERSLAKE, Susan
    8 The Common
    KT21 2ED Ashtead
    Surrey
    Segretario
    8 The Common
    KT21 2ED Ashtead
    Surrey
    British1320390001
    MAIR, Kenneth
    3 Smithy Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6TP Tadworth
    Surrey
    Segretario
    3 Smithy Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6TP Tadworth
    Surrey
    British545490001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Segretario
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    BritishAccountant148459300001
    MELLER, Stephen Daniel
    60 Wayside Avenue
    Bushey
    WD2 3SQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    60 Wayside Avenue
    Bushey
    WD2 3SQ Watford
    Hertfordshire
    British70938260002
    PROBERT, John Robert
    1 Meitner Close
    Bramley
    RG26 5NQ Tadley
    Hampshire
    Segretario
    1 Meitner Close
    Bramley
    RG26 5NQ Tadley
    Hampshire
    British34786610001
    RANKEN & REID SSC
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    36900001
    TODS MURRAY LLP
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Segretario
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    1117600001
    BADCOCK, Peter Colin
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director545530001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Amministratore
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritishDirector91412650001
    BURMAN, Barry William
    Little Orchard 3 Winchelsey Rise
    CR2 7BP South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Little Orchard 3 Winchelsey Rise
    CR2 7BP South Croydon
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director50817240001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director6069370001
    CHISHOLM, Allan Donald
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    Amministratore
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director545510001
    COCHRANE, Gordon
    95 Ayr Road
    Newton Mearns
    G77 6QR Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    95 Ayr Road
    Newton Mearns
    G77 6QR Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director545540001
    COOK, Alexander Kinnison
    10 Station Road East
    Peterculter
    AB1 0PT Aberdeen
    Amministratore
    10 Station Road East
    Peterculter
    AB1 0PT Aberdeen
    BritishCompany Director545520001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishDirector9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    FOSTER, David Martin
    37 Thellusson Way
    WD3 2RD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    37 Thellusson Way
    WD3 2RD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England
    BritishDirector50285750001
    FOSTER, David Martin
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Bear Park
    31 Nightingale Road
    WD3 7DA Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector50285750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    KINGSTON, Richard David
    4 Rookes
    Little Walden Road
    CB10 2EP Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    4 Rookes
    Little Walden Road
    CB10 2EP Saffron Walden
    Essex
    BritishAccountant10789160001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MALDE, Nishith
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tudor House
    69 Camlet Way
    EN4 0NL Hadley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant148459300001
    WICKS, Stephen Desmond
    Harefield House High Street
    Harefield
    UB9 6RH Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    Harefield House High Street
    Harefield
    UB9 6RH Uxbridge
    Middlesex
    BritishDirector42298130001
    WICKS, Stephen Desmond
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Sherwood House
    Oxhey Drive
    HA6 3EU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector42298130002
    WILSON, Derek Robert
    The Spinney Misbourne Avenue
    Chalfont St Peter
    SL9 0PF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Spinney Misbourne Avenue
    Chalfont St Peter
    SL9 0PF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director34786640001

    BREDERO HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Floating charge
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 17 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 30 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 07 set 1993
    Consegnato il 21 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by bredoro properties PLC and certain subsidiaries
    Brevi particolari
    Sites d, e, f candlemakers lane, loch street, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 21 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 01 set 1993
    Consegnato il 21 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by bredero properties PLC or its subsidiaries
    Brevi particolari
    The whole of the property (including goodwill and uncalled capital) which shall comprise in the company's undertaking, property and assets but excluding therefrom the company's right title and interest in and to any proceeds from the sale of the property at candlemakers lane, aberdeen (formerly known as city taxis) or any part thereof.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee
    Transazioni
    • 21 set 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 21 giu 1993
    Consegnato il 25 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    (First) an area of ground extending to 396.9 sq metres lying to the east of loch street aberdeen (second) a 20/72 ndth share pro indiviso of that area of ground extending to 2750.92 sq metres also lying to the east of loch street (third) a 20/72NDTH share pro indiviso of a right of common property in that area of ground extending to 164.4 sq metres or thereby lying also to the east of loch street in the said district and county.
    Persone aventi diritto
    • Barratt Construction Limited
    Transazioni
    • 25 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 11 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 04 mag 1990
    Consegnato il 04 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    15 warren road, purley and land at the rear of 9, 11 & 13 warren road purley.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 09 ott 1989
    Consegnato il 20 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    68/70 ash tree way and land at 14/24 fairway close, croydon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 1989
    Consegnato il 21 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land rear of 20 to 24 fairway close, shirley.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 20 set 1988
    Consegnato il 23 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    68 ashtree way, croydon, surrey. Sy 3912.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 25 feb 1988
    Consegnato il 29 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    40 selcroft road and land to the rear.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 25 set 1987
    Consegnato il 05 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land to the rear of 19-31 church hill inclusive and longacre great woodcote park.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1987
    Consegnato il 10 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    14 fairway close, shirley, croydon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1987
    Consegnato il 04 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    18 fairway close shirley croydon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1987
    Consegnato il 04 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    16 fairway close shirley croydon title no sg 1208.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1987
    Consegnato il 04 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    70 ash tree way shirley, croydon title no sy 6228.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1987
    Consegnato il 11 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at beckenham place park, beckenham, kent.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1987
    Consegnato il 11 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    198 pampisford rd, croydon, surrey.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1987
    Consegnato il 11 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    3 overbury ave, beckenham, kent.
    Transazioni
    • 11 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 22 lug 1987
    Consegnato il 11 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at homefield road, warlingham, surrey.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 mar 1986
    Consegnato il 19 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piece of ground along the south side of union grove, aberdeen part of lands of cuparstone aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 ago 1985
    Consegnato il 03 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground south west of gordon st. And south east of bon accord lane aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 05 mar 1985
    Consegnato il 13 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    940 sq. Metres to the south west of don street aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 ago 1984
    Consegnato il 04 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Ground north of marywell street, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 29 giu 1984
    Consegnato il 16 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land at binghill, milltimber.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0