SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED

SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC055493
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio dall'amministrazione allo scioglimento

    38 pagine2.26B(Scot)

    Proposta riveduta dell'amministratore

    2 pagine2.17B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    31 pagine2.20B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    29 pagine2.20B(Scot)

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.29B(Scot)

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.29B(Scot)

    Proposta presunta dell'amministratore

    1 pagine2.16BZ(Scot)

    Stato patrimoniale con modulo allegato 2.13B(Scot)

    17 pagine2.15B(Scot)

    Proposta dell'amministratore

    147 pagine2.16B(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL Scotland a C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL in data 26 set 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA a C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL in data 15 set 2014

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Michael Edward Jourdain come amministratore in data 01 ago 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Procopis come amministratore in data 01 ago 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Declan Mckelvey come amministratore in data 01 ago 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2014

    Stato del capitale al 28 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,461,436.8
    SH01

    Cessazione della carica di David Kaye come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Kaye come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCKELVEY, Declan
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    EnglandIrish172282530001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Segretario
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    British1244320001
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Segretario
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    British39828490004
    KAYE, David Robert
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    Segretario
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    British110817160002
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Segretario
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Amministratore
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    British1244320001
    CAMPBELL, Colin John
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British99161140001
    DAVIES, Tudor Griffith
    Home Farm
    The Hendre
    NP25 5HH Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Home Farm
    The Hendre
    NP25 5HH Monmouth
    Gwent
    WalesWelsh68085230001
    GALGANI, Franco
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    British43293400002
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Amministratore
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    United KingdomBritish39828490004
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    Amministratore
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    British37900003
    JOURDAIN, Michael Edward
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    Amministratore
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    EnglandBritish58412670001
    KAYE, David Robert
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    Amministratore
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    United KingdomBritish110817160002
    KENNEDY, James Adam
    Blacklaw Drumbeg Loan
    Killearn
    G63 9LG Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Blacklaw Drumbeg Loan
    Killearn
    G63 9LG Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish70674950001
    MARCOVECCHIO, Massimo Mario
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Amministratore
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritish75936930001
    PAISNER, Jonathan Samuel
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Amministratore
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    United KingdomBritish78399950005
    PROCOPIS, Peter
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    Amministratore
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    United KingdomAustralian66047970002
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Amministratore
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrish7856280001
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41216370001
    SIMMERS, Brian Maxwell
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1064940001
    SIMMERS, Graeme Maxwell
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    Amministratore
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    ScotlandBritish1064950001
    SMITH, Paul Murray
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    British1064970001

    SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of rents
    Creato il 24 lug 2009
    Consegnato il 28 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Right, title and interest in rental income over marine hotel, troon.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Corporation Limited
    Transazioni
    • 28 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Deed of confirmation
    Creato il 07 lug 2009
    Consegnato il 21 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Variation of previously registered floating charge, assignation of rents and standard securities-see form for further details.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Assignation of rents
    Creato il 05 set 2007
    Consegnato il 13 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Rental income under the lease of paramount marine hotel, 8 crosby road, troon.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Corporation PLC
    Transazioni
    • 13 set 2007Registrazione di un'ipoteca (410)
    Supplemental legal charge
    Creato il 13 lug 2005
    Consegnato il 01 ago 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the transaction documents and under the debenture
    Brevi particolari
    First legal mortgage over the company's right, title and interest in and to the land on the north east side of highside road, heighington (title number DU188641) and 4 other properties...see mortgage document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 22 lug 2004
    Consegnato il 02 ago 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The subjects known as the marine highland hotel, troon, in the county of ayr.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 02 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 12 lug 2004
    Consegnato il 20 set 2005
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 20 set 2005Registrazione di un'ipoteca (410)
    Share pledge
    Creato il 12 lug 2004
    Consegnato il 23 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due under the transaction documents
    Brevi particolari
    Assignation of existing shares and further shares...see mortgage doucment for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 23 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 12 lug 2004
    Consegnato il 16 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transazioni
    • 16 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 12 apr 2002
    Consegnato il 18 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or pursuant to the secured documents
    Brevi particolari
    The old waverley hotel, 43 princes street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V., London Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 12 apr 2002
    Consegnato il 18 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due under or pursuant to any of the secured documents
    Brevi particolari
    The marine highland hotel, troon.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V., London Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 04 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 21 mar 2002
    Consegnato il 08 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over the property known as redworth hall, redworth, darlington, durham.
    Persone aventi diritto
    • Nb Capital Bank Nv
    Transazioni
    • 08 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 04 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Marine highland hotel, troon.
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 04 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 13 lug 2000
    Consegnato il 27 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transazioni
    • 27 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 gen 2000
    Consegnato il 03 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The marine highland hotel, troon; the old waverley hotel, 43 princes street, edinburgh; the buchanan arms hotel, drymen.
    Persone aventi diritto
    • De Nationale Investeringsbank N.V.
    Transazioni
    • 03 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 13 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property known as redworth hall, redworth, darlington, durham and property known as hellaby hall, hellaby lane, bramley, rotherham.
    Persone aventi diritto
    • De Nationale Investeringsbank N.V.
    Transazioni
    • 13 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 25 giu 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (419b)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 13 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • De Nationale Investeringbank N.V.
    Transazioni
    • 13 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 24 ott 1991
    Consegnato il 31 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The clarendon hotel grosvenor street edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 24 ott 1991
    Consegnato il 31 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The marine highland hotel, crosbie road troon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 24 ott 1991
    Consegnato il 31 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The pitlochry hydro hotel, pitlochry.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 ott 1988
    Consegnato il 17 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The buchan arms hotel, drymen comprising 3.615 acres.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 27 mag 1988
    Consegnato il 03 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The buchanan arms drymen stirlingshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 mag 1988
    Consegnato il 24 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Old waverley hotel, princes street, edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 mag 1988
    Consegnato il 20 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    8/18 main street, drymen 20/34 main street, drymen.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 10 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 mag 1988
    Consegnato il 24 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Sutherland arms hotel lairg sutherland.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 03 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    SCOTTISH HIGHLAND HOTELS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 set 2014Inizio dell'amministrazione
    10 set 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    David John Whitehouse
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul John Clark
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0