GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED

GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC055629
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BETT HOMES (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED27 apr 200527 apr 2005
    BETT HOMES (SCOTLAND) LIMITED29 gen 200429 gen 2004
    BETT HOMES LIMITED11 nov 199211 nov 1992
    BETT ESTATES LIMITED09 mag 198609 mag 1986
    SPALDING (INSURANCE BROKERS) LIMITED09 mag 197409 mag 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Fitzsimmons il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Elizabeth Catchpole come amministratore in data 20 giu 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2012

    Stato del capitale al 14 mar 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di James Mclellan Kirkpatrick come amministratore in data 11 lug 2011

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Stato del capitale al 09 set 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di David Gaffney come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Colin Edward Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Neil Fitzsimmons come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ in data 02 feb 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per David Gaffney il 29 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Lavelle come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809240001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector154997530001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050003
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Segretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Segretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritishManaging Director114144470001
    BARLOW, David St John
    Inglewood
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Amministratore
    Inglewood
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    BritishLand Buyer40287360005
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Amministratore
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritishBuilder95179330001
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Amministratore
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    BritishCivil Engineer318650001
    CHURCH, Charles
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    Amministratore
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    United KingdomBritishLand Director79873860001
    CLARK, James
    48 Garvine Road
    Coylton
    KA6 6NZ Ayr
    Amministratore
    48 Garvine Road
    Coylton
    KA6 6NZ Ayr
    BritishCommercial Director37854600001
    CLELLAND, Lorraine Agnes
    9 Alexander Gordon Drive
    Monifieth
    DD5 4HD Dundee
    Angus
    Amministratore
    9 Alexander Gordon Drive
    Monifieth
    DD5 4HD Dundee
    Angus
    BritishSales & Marketing Director102629370001
    DAVIDSON, Kareen
    85 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    85 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Fife
    BritishHouse Sales Manager44746080001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35117250001
    DOUGLAS, Keith Richard
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    Amministratore
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    United KingdomBritishAccountant91229410003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Amministratore
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Amministratore
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Amministratore
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    BritishEstates Manager318180001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Amministratore
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    BritishFinance Director107801990001
    HALDANE, Kenneth Douglas
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    United KingdomBritishLand Director94477860001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishChief Executive8506940001
    HAWKSBY, Terry
    Newbigging Farmhouse
    Tibbermore
    PH1 1QH Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Newbigging Farmhouse
    Tibbermore
    PH1 1QH Perth
    Perthshire
    United KingdomBritishManaging Director93733930001
    HITCHEN, David James
    4 Carrongrove Avenue
    Carron
    FK2 8NG Falkirk
    Amministratore
    4 Carrongrove Avenue
    Carron
    FK2 8NG Falkirk
    BritishConstruction Director60512890001
    INNES, John Gordon
    14 Limeview Road
    Glenburn
    PA2 8ND Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    14 Limeview Road
    Glenburn
    PA2 8ND Paisley
    Renfrewshire
    BritishTechnical Director72090910001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector102797820001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishTechnical Dir102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Amministratore
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    BritishDirector110231420001
    LYON, Steven
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    Amministratore
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    UkBritishFinance Director97482510001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector147233120001
    MCGOWAN, James Joseph
    66 Mulben Crescent
    Crookston
    G53 7EH Glasgow
    Amministratore
    66 Mulben Crescent
    Crookston
    G53 7EH Glasgow
    BritishConstruction Director77647430001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Amministratore
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    BritishArchitect318190001

    GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 14 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 30 dic 2008
    Consegnato il 08 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (410)
    Floating charge
    Creato il 21 mag 2003
    Consegnato il 03 giu 2003
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    Letter of offset
    Creato il 10 apr 1984
    Consegnato il 24 apr 1984
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and/or others
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of spalding (insurance brokers) LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 apr 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0