RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED

RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC055754
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    • (6024) /

    Dove si trova RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pricewaterhousecoopers
    PO BOX 90 Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICHARD LAWSON MOTOR COMPANY LIMITED08 giu 197408 giu 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al04 gen 2003

    Quali sono le ultime deposizioni per RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ordinanza giudiziaria

    Order of court - dissolution void
    1 pagineOC-DV

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ordinanza giudiziaria

    Order of court - dissolution void
    1 pagineOC-DV

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Avviso di fine automatica dell'amministrazione

    7 pagine2.21B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    8 pagine2.20B(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    2 pagine2.22B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    8 pagine2.20B(Scot)

    Avviso di proroga del periodo di amministrazione

    2 pagine2.22B(Scot)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore

    10 pagine2.20B(Scot)

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    40 pagine2.18B(Scot)

    Stato patrimoniale

    37 pagine2.15B(Scot)

    legacy

    1 pagine288b

    Proposta dell'amministratore

    40 pagine2.16B(Scot)

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.11B(Scot)

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio consolidato redatto al 04 gen 2003

    20 pagineAA

    Bilancio consolidato redatto al 30 dic 2001

    21 pagineAA

    legacy

    9 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FYFE, Alexander
    27 Seaforth Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 1QD Dundee
    Angus
    Segretario
    27 Seaforth Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 1QD Dundee
    Angus
    British72003050001
    GISVOLD, Rune
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Amministratore
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Norwegian85499620001
    HOLM, Aage Sturtzel
    Bekkeveien 1b
    1336 Sandvika
    Norway
    Amministratore
    Bekkeveien 1b
    1336 Sandvika
    Norway
    Norwegian66364500001
    COWIE, John Michael
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    Segretario
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    British543350001
    NICOLL, Douglas John
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    British166730001
    WILSON, Kenneth
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    British53458580002
    BRUERS, Georges
    Guyotdreef 26
    2930 Brasschaat
    Belgium
    Amministratore
    Guyotdreef 26
    2930 Brasschaat
    Belgium
    Belgium33794790001
    COWIE, John Michael
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    Amministratore
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    ScotlandBritish543350001
    EUREN, Bengt Ingvar Lennart
    Vindragarvagen 12
    Stockholm
    11750
    Sweden
    Amministratore
    Vindragarvagen 12
    Stockholm
    11750
    Sweden
    Swedish57830000001
    HAGEL, Lennart Nils Fredrik
    Trossvagen 2
    S 181 66 Lidingo
    Sweden
    Amministratore
    Trossvagen 2
    S 181 66 Lidingo
    Sweden
    SwedenSwedish36224910001
    HAYNES, Peter Davis
    19 Buckland
    Shoeburyness
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    Amministratore
    19 Buckland
    Shoeburyness
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    British3387810001
    LAWSON, Richard Herring
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    Amministratore
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    ScotlandBritish146501290001
    LAWSON, Susan Janet
    Winsterley 23 Reres Road
    Broughty Ferry
    DD5 2QA Dundee
    Angus
    Amministratore
    Winsterley 23 Reres Road
    Broughty Ferry
    DD5 2QA Dundee
    Angus
    British166750001
    MACKAY, Ian
    Tall Chambers
    45 Saint Wilfrids Road
    DN4 6AB Doncaster
    South Yorks
    Amministratore
    Tall Chambers
    45 Saint Wilfrids Road
    DN4 6AB Doncaster
    South Yorks
    British85693920001
    NICOLL, Douglas John
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    British166730001
    OLSSON, Christer Bengt
    Grev Turegatan 75
    S-114 38
    Stockholm
    Sweden
    Amministratore
    Grev Turegatan 75
    S-114 38
    Stockholm
    Sweden
    Swedish21234530001
    REEVES, Martin Charles
    Crestover Christmas Hill
    South Wonston
    SO21 3ES Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Crestover Christmas Hill
    South Wonston
    SO21 3ES Winchester
    Hampshire
    British22890000001
    SKAUG, Odd Ingar
    Mariesvei 18b
    N-1363 Hevik
    Norway
    Amministratore
    Mariesvei 18b
    N-1363 Hevik
    Norway
    Norwegian64835160001
    STYER, Richard
    Minimus Cottage
    BA7 7DJ Castle Cary
    Somerset
    Amministratore
    Minimus Cottage
    BA7 7DJ Castle Cary
    Somerset
    British1133930001
    VAN MOL, Walter Petrus Maria
    Rood Borstlaan 17
    FOREIGN 2660 Antwerp
    Belgium
    Amministratore
    Rood Borstlaan 17
    FOREIGN 2660 Antwerp
    Belgium
    Dutch5666990001
    WILSON, Kenneth
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    British53458580002

    RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 31 ago 1999
    Consegnato il 17 set 1999
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Legal charge over property known as lima, block a, bourne business park, weybridge; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 set 1999Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 31 gen 1997
    Consegnato il 07 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground on the south east side of cortachy road,kirriemuir.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (410)
    Legal charge
    Creato il 08 feb 1995
    Consegnato il 20 feb 1995
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Land on the south side of rossfield road, ellesmere port, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    Bond & floating charge
    Creato il 13 giu 1994
    Consegnato il 21 giu 1994
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 02 feb 1989
    Consegnato il 08 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Cortachir road kirriemuir, angus.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1988
    Consegnato il 05 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Parcel of land and buildings thereon situate the south side of rossfield road ch 131908.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Aircraft mortgage
    Creato il 21 mar 1988
    Consegnato il 29 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £88,200 and all sums due or to become due
    Brevi particolari
    One 1976 cessing 421C golden eagle aircraft reg. Mark g-rlmc serial no-421C 0118.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 01 feb 1988
    Consegnato il 08 feb 1988
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Piece of ground lying on or towards the southeast side of cortachy road in the parish of kirriemuir and county of angus (formerly forfar) sometime forming part of the lands and estate of hillhead in said parish and county and (second) all and whole that area or piece of ground in the said parish and county extending to thirty four decimal parts of a hectare or thereby.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 25 gen 1983
    Consegnato il 10 feb 1983
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Garage and warehouse premises at 51 dundonald street, dundee, angus.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 03 ott 1975
    Consegnato il 13 ott 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:

    RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 set 2004Inizio dell'amministrazione
    13 giu 2006Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Praticante
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Praticante
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Robert Hunt
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Praticante
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Praticante
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0