SCOTT CHEMISTS LIMITED

SCOTT CHEMISTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCOTT CHEMISTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC057694
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Boots - North 3rd Floor
    79 - 91 High Street
    FK1 1ES Falkirk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IAN MONACHAN LIMITED08 mag 197508 mag 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2013

    Stato del capitale al 04 dic 2013

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Stato del capitale al 07 nov 2013

    • Capitale: GBP 10
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Boots Divisional Office Unit 10 Gyle Park Shopping Centre Edinburgh EH12 9JR Scotland* in data 09 set 2013

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 25 in pieno

    3 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Christopher Giles come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Alliance Pharmacy Reg Office Unit 3C Fairways Business Park Deer Park Avenue, Livingston West Lothian EH54 8AF* in data 26 gen 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Nomina di David Charles Geoffrey Foster come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di David Charles Geoffrey Foster come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Prosser come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Patricia Kennerley come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Aylward come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SCOTT CHEMISTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    Thane Road
    NG90 1BS Nottingham
    D90, 1
    Segretario
    Thane Road
    NG90 1BS Nottingham
    D90, 1
    British150374240001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritishSolicitor150818000001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Amministratore
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritishDirector63620010002
    BENNETT, Alexander
    37 Middlewood Park
    EH54 8AZ Livingston
    West Lothian
    Segretario
    37 Middlewood Park
    EH54 8AZ Livingston
    West Lothian
    British307350001
    GOODENOUGH, Adrian John
    30 Glebe Hyrst
    CR2 9JE Sanderstead
    Surrey
    Segretario
    30 Glebe Hyrst
    CR2 9JE Sanderstead
    Surrey
    British2584980002
    MONACHAN, Ian Mcgregor
    8 Rue De La Douzaine
    Fort George
    CHANNEL St Peters Port
    Guernsey
    Channel Isles
    Segretario
    8 Rue De La Douzaine
    Fort George
    CHANNEL St Peters Port
    Guernsey
    Channel Isles
    BritishPharmacist1092950002
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Tamarind
    Camilla Drive Westhumble
    RH5 6BU Dorking
    Surrey
    Segretario
    Tamarind
    Camilla Drive Westhumble
    RH5 6BU Dorking
    Surrey
    BritishFinance Director151240810001
    AU COSEC LIMITED
    2 The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    Surrey
    Segretario
    2 The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    Surrey
    68799430002
    ANDREWS, Barry Michael
    10 East Lane
    KT24 6HL West Horsley
    Surrey
    Amministratore
    10 East Lane
    KT24 6HL West Horsley
    Surrey
    BritishPharmacist26879300001
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Amministratore
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritishDirector Of Business Developme59741430002
    BENNETT, Alexander
    37 Middlewood Park
    EH54 8AZ Livingston
    West Lothian
    Amministratore
    37 Middlewood Park
    EH54 8AZ Livingston
    West Lothian
    BritishChemist307350001
    DOCHERTY, Anne Marie
    27 Avon Street
    ML1 3AA Motherwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    27 Avon Street
    ML1 3AA Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishChemist307400001
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritishAccountant150046230001
    GOODENOUGH, Adrian John
    30 Glebe Hyrst
    CR2 9JE Sanderstead
    Surrey
    Amministratore
    30 Glebe Hyrst
    CR2 9JE Sanderstead
    Surrey
    BritishChartered Secretary2584980002
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Amministratore
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritishPharmacist110727230002
    MILTON, John Douglas
    32 Eastwoodmains Road
    Giffnock
    G46 6QF Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    32 Eastwoodmains Road
    Giffnock
    G46 6QF Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChemist35704950002
    MONACHAN, Ian
    8 Rue De La Douzaine
    Fort George
    St Peters Port
    Guernsey
    Channel Isles
    Amministratore
    8 Rue De La Douzaine
    Fort George
    St Peters Port
    Guernsey
    Channel Isles
    BritishChemist8685200002
    MONACHAN, Jennifer
    Stanley Drive
    PA5 8 Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    Stanley Drive
    PA5 8 Johnstone
    Renfrewshire
    BritishHousewife307370001
    MORRISON, Joyce
    12 Rossie Crescent
    Bishopbriggs
    G64 1AP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    12 Rossie Crescent
    Bishopbriggs
    G64 1AP Glasgow
    Lanarkshire
    BritishChemist17647610001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant63620010002
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Tamarind
    Camilla Drive Westhumble
    RH5 6BU Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Tamarind
    Camilla Drive Westhumble
    RH5 6BU Dorking
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director151240810001
    SCICLUNA, Terence Joseph
    1 Pennymead Place
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    Amministratore
    1 Pennymead Place
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    EnglandBritishOperations Director185155550001
    E.MOSS LIMITED
    Fern House
    53-55 High Street
    TW13 4HU Feltham
    Middlesex
    Amministratore
    Fern House
    53-55 High Street
    TW13 4HU Feltham
    Middlesex
    33973430003

    SCOTT CHEMISTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 12 nov 1990
    Consegnato il 23 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £152,000 and all sums due or to become due
    Brevi particolari
    Plot 24 2, 5/2, 130 clyde street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Dunfermline Building Society
    Transazioni
    • 23 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Mandate
    Creato il 25 ott 1990
    Consegnato il 30 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    £152,000 from dunfermline building society account no 173260.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 28 set 1990
    Consegnato il 12 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 3 the olympia east kilbride lan 64426.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 set 1990
    Consegnato il 28 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop 403 sauchiehall street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 24 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 15 mar 1990
    Consegnato il 04 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    75/4 lancefield quay glasgow gla 59108.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 14 feb 1990
    Consegnato il 22 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    30 bowen craig beach estate largs.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 20 apr 1989
    Consegnato il 26 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises 80 queen margaret dr. Glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 24 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 nov 1988
    Consegnato il 18 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Unit 22A the forge, parkhead, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 19 apr 1988
    Consegnato il 29 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises 66/68 main street, prestwick.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 24 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 set 1987
    Consegnato il 09 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Units 3 & 4 forming part of 138/152 paisley rd renfrew.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 24 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 23 giu 1987
    Consegnato il 26 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due and to become due by ayrshire & arran health board, finance department.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 21 mag 1986
    Consegnato il 30 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due and to become due to the company in respect of prescription fees by lanarkshire health board.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 21 mag 1986
    Consegnato il 30 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due and to become due to the company in respect of prescription fees by the argyll and clyde health board.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 21 mag 1986
    Consegnato il 30 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due and to become due to the company in respect of prescription fees by the lothian health board.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Assignation
    Creato il 21 mag 1986
    Consegnato il 30 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    All sums due and to become due to the company in respect of prescription fees by the greater glasgow health board.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 17 giu 1985
    Consegnato il 05 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    A lease of all & whole that shop 209 & 211 byres rd glasgow & 1 dowanside rd.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 16 ago 1976
    Consegnato il 30 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises 76/78 union street, larkhall.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1976Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 09 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 16 ago 1976
    Consegnato il 30 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises 12 sycamore walk blackburn.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 16 ago 1976
    Consegnato il 30 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises 26 kirk road wishaw.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 16 ago 1976
    Consegnato il 30 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises 14 glasgow road eaglesham.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 16 ago 1976
    Consegnato il 30 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Shop premises, 63 hillfoot street, dunoon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 06 mag 1976
    Consegnato il 14 mag 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4550
    Brevi particolari
    12 sycamore walk blackburn.
    Persone aventi diritto
    • Standard Property Investment Co LTD
    Transazioni
    • 14 mag 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 29 apr 1976
    Consegnato il 20 mag 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 10 mag 1975
    Consegnato il 25 giu 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4200
    Brevi particolari
    14 glasgow road eaglesham.
    Persone aventi diritto
    • Standard Property Investment Co LTD
    Transazioni
    • 25 giu 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 01 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0