THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC058099 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
- Attività di supporto per l'estrazione di petrolio e gas naturale (09100) / Attività estrattive
Dove si trova THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum Aberdeenshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| STOLT-NIELSEN SEAWAY (U.K.) LIMITED | 08 mar 1990 | 08 mar 1990 |
| STOLT-NIELSEN SEAWAY CONTRACTING LIMITED | 21 giu 1985 | 21 giu 1985 |
| STOLT-NEILSEN SEAWAY LIMITED | 02 lug 1975 | 02 lug 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Nomina di Mr James Henry John Marsh come segretario in data 03 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Hoggan come segretario in data 03 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Graham Marsh il 01 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael John Howarth come amministratore in data 13 ago 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Giovanni Corbetta come amministratore in data 05 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere SC0580990012 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 123 Ashgrove Road West Aberdeen AB16 5FA a C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows Oldmeldrum Aberdeenshire AB51 0GC in data 12 feb 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Michael Hoggan come segretario in data 09 feb 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Russell Smith come amministratore in data 09 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Russell Smith come segretario in data 09 feb 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Martin Graham Marsh come amministratore in data 09 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael John Howarth come amministratore in data 09 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Modifiche a una garanzia mobiliare | 11 pagine | 466(Scot) | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH, James Henry John | Segretario | Michaelson Road LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria United Kingdom | 235026530001 | |||||||
| CORBETTA, Giovanni | Amministratore | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | Scotland | British | 160476180001 | |||||
| MARSH, Martin Graham | Amministratore | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 194923760001 | |||||
| HOGGAN, Michael | Segretario | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | 194965170001 | |||||||
| SMITH, David Russell | Segretario | Manor House Midmar AB51 7LX Inverurie Aberdeenshire | British | 20205140001 | ||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Segretario | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| STOLT OFFSHORE M.S. LIMITED | Segretario | Bucksburn House Howes Road AB16 7QU Aberdeen Aberdeenshire | 74739410001 | |||||||
| ANDERSEN, Ole Christian | Amministratore | 47 Marischal Street AB1 2AB Aberdeen | Norwegian | 1300200003 | ||||||
| ANDERSON, Ole Christian | Amministratore | 33 Stenderveien 5542 Karsmund Haugesund | British | 1300200001 | ||||||
| BRANNAN, Thomas | Amministratore | Cluniter Road Innellan PA23 7SA Dunoon 3 Calderwood | Scotland | British | 140573350001 | |||||
| BRUNNEN, Jeremy Alan | Amministratore | 6 Clarence Lodge Middle Hill TW20 0NW Egham Surrey | British | 44706880003 | ||||||
| CHABAS, Bruno Yves Raymond | Amministratore | 8 Western Road RG9 1JL Henley On Thames | French | 66271250006 | ||||||
| FRIKSTAD, Paul Arild | Amministratore | 3a Rubislaw Don North AB15 4AL Aberdeen | Norwegian | 86298910001 | ||||||
| HIRST, Terence John | Amministratore | 73 Kings Gate AB2 6BN Aberdeen Grampian Scotland | British | 39503560001 | ||||||
| HOWARTH, Michael John | Amministratore | 123 Ashgrove Road West AB16 5FA Aberdeen National Hyperbaric Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 172532620001 | |||||
| JOHN, Michael Dendle | Amministratore | Dundas Yews EH34 5DS Pencaitland | British | 641280001 | ||||||
| LIE, Kaare Johannes | Amministratore | Fiolvegen 1 FOREIGN Haugesund Norway | Norwegian | 1336280001 | ||||||
| MACKIE, Grahame John Sinclair | Amministratore | 35 Hammersmith Road AB1 6NA Aberdeen Aberdeenshire | British | 676720001 | ||||||
| MELING, Jan Fredrik | Amministratore | Naumdoelaveien 18 FOREIGN Haugesund Norway | Norwegian | 1336290001 | ||||||
| MIKAELSEN, Oeyvind | Amministratore | Ragnh Ildsgate 48 4044 Hafrsejord Norway | Norwegian | 91267430001 | ||||||
| OAKLEY, Stuart David | Amministratore | Castleton House 15 The Chanonry AB24 1RP Aberdeen Aberdeenshire Scotland | British | 38261820001 | ||||||
| SKOUVEROE, Jan Frithjof | Amministratore | Lillevannsveien 12c FOREIGN 0390 Oslo 3 Norway | Norwegian | 25049690001 | ||||||
| SMITH, David Russell | Amministratore | Manor House Midmar AB51 7LX Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 20205140001 | |||||
| SVENSON, Einar Wold | Amministratore | 3 Haraldskroken 4041 Hafrsfjord | British | 1396780001 | ||||||
| VOSSIER, Bernard Lucien | Amministratore | Bede House Court 54 Don Street AB2 1UU Aberdeen | French | 44196670001 | ||||||
| WEBSTER, Gary Roderick | Amministratore | 3 Bograxie Burnhervie AB51 5LD Inverurie | Scotland | British | 1130100002 | |||||
| WEBSTER, Gary Roderick | Amministratore | 3 Bograxie Burnhervie AB51 5LD Inverurie | Scotland | British | 1130100002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Safety Management Limited | 06 apr 2016 | Oldmeldrum 4 AB51 0DG Inverurie Fisher Offshore Westbank Park Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 10 giu 2014 Consegnato il 19 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Standard security | Creato il 14 dic 2004 Consegnato il 17 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Tenants interest in 2.9 acres at 123 ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 02 dic 2004 Consegnato il 11 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Standard security | Creato il 15 mag 1992 Consegnato il 27 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Leasehold interest in 123 ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 15 mag 1992 Consegnato il 27 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground extending to 2.9 acres or thereby lying to the south-east of ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 21 gen 1991 Consegnato il 04 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 24 ago 1990 Consegnato il 29 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
| Standard security | Creato il 16 lug 1990 Consegnato il 27 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Loirston cottage cove bay nigg. | ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 29 mag 1990 Consegnato il 06 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Loirston cottage cove bay nigg. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 30 mar 1987 Consegnato il 06 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of offset | Creato il 19 mar 1987 Consegnato il 27 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by seaway technology and another | |
Brevi particolari Balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of stolt-nielsen seaway contracting limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 19 mar 1987 Consegnato il 27 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The whole assets of the company. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0