THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED

THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC058099
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    • Attività di supporto per l'estrazione di petrolio e gas naturale (09100) / Attività estrattive

    Dove si trova THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O James Fisher Offshore Limited
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    Aberdeenshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STOLT-NIELSEN SEAWAY (U.K.) LIMITED08 mar 199008 mar 1990
    STOLT-NIELSEN SEAWAY CONTRACTING LIMITED21 giu 198521 giu 1985
    STOLT-NEILSEN SEAWAY LIMITED02 lug 197502 lug 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Nomina di Mr James Henry John Marsh come segretario in data 03 lug 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Hoggan come segretario in data 03 lug 2017

    1 pagineTM02

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2015

    Stato del capitale al 21 ott 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Graham Marsh il 01 set 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael John Howarth come amministratore in data 13 ago 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giovanni Corbetta come amministratore in data 05 ago 2015

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere SC0580990012 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da 123 Ashgrove Road West Aberdeen AB16 5FA a C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows Oldmeldrum Aberdeenshire AB51 0GC in data 12 feb 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Michael Hoggan come segretario in data 09 feb 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Russell Smith come amministratore in data 09 feb 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Russell Smith come segretario in data 09 feb 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Martin Graham Marsh come amministratore in data 09 feb 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael John Howarth come amministratore in data 09 feb 2015

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 08 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 set 2014

    Stato del capitale al 11 set 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Modifiche a una garanzia mobiliare

    11 pagine466(Scot)

    Chi sono gli amministratori di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARSH, James Henry John
    Michaelson Road
    LA14 1HR Barrow-In-Furness
    Fisher House
    Cumbria
    United Kingdom
    Segretario
    Michaelson Road
    LA14 1HR Barrow-In-Furness
    Fisher House
    Cumbria
    United Kingdom
    235026530001
    CORBETTA, Giovanni
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    C/O James Fisher Offshore Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Amministratore
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    C/O James Fisher Offshore Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish160476180001
    MARSH, Martin Graham
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    C/O James Fisher Offshore Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Amministratore
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    C/O James Fisher Offshore Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish194923760001
    HOGGAN, Michael
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    C/O James Fisher Offshore Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Segretario
    North Meadows
    AB51 0GC Oldmeldrum
    C/O James Fisher Offshore Limited
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    194965170001
    SMITH, David Russell
    Manor House
    Midmar
    AB51 7LX Inverurie
    Aberdeenshire
    Segretario
    Manor House
    Midmar
    AB51 7LX Inverurie
    Aberdeenshire
    British20205140001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Segretario
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    STOLT OFFSHORE M.S. LIMITED
    Bucksburn House
    Howes Road
    AB16 7QU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    Bucksburn House
    Howes Road
    AB16 7QU Aberdeen
    Aberdeenshire
    74739410001
    ANDERSEN, Ole Christian
    47 Marischal Street
    AB1 2AB Aberdeen
    Amministratore
    47 Marischal Street
    AB1 2AB Aberdeen
    Norwegian1300200003
    ANDERSON, Ole Christian
    33 Stenderveien
    5542
    Karsmund
    Haugesund
    Amministratore
    33 Stenderveien
    5542
    Karsmund
    Haugesund
    British1300200001
    BRANNAN, Thomas
    Cluniter Road
    Innellan
    PA23 7SA Dunoon
    3 Calderwood
    Amministratore
    Cluniter Road
    Innellan
    PA23 7SA Dunoon
    3 Calderwood
    ScotlandBritish140573350001
    BRUNNEN, Jeremy Alan
    6 Clarence Lodge
    Middle Hill
    TW20 0NW Egham
    Surrey
    Amministratore
    6 Clarence Lodge
    Middle Hill
    TW20 0NW Egham
    Surrey
    British44706880003
    CHABAS, Bruno Yves Raymond
    8 Western Road
    RG9 1JL Henley On Thames
    Amministratore
    8 Western Road
    RG9 1JL Henley On Thames
    French66271250006
    FRIKSTAD, Paul Arild
    3a Rubislaw Don North
    AB15 4AL Aberdeen
    Amministratore
    3a Rubislaw Don North
    AB15 4AL Aberdeen
    Norwegian86298910001
    HIRST, Terence John
    73 Kings Gate
    AB2 6BN Aberdeen
    Grampian
    Scotland
    Amministratore
    73 Kings Gate
    AB2 6BN Aberdeen
    Grampian
    Scotland
    British39503560001
    HOWARTH, Michael John
    123 Ashgrove Road West
    AB16 5FA Aberdeen
    National Hyperbaric Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    123 Ashgrove Road West
    AB16 5FA Aberdeen
    National Hyperbaric Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish172532620001
    JOHN, Michael Dendle
    Dundas Yews
    EH34 5DS Pencaitland
    Amministratore
    Dundas Yews
    EH34 5DS Pencaitland
    British641280001
    LIE, Kaare Johannes
    Fiolvegen 1
    FOREIGN Haugesund
    Norway
    Amministratore
    Fiolvegen 1
    FOREIGN Haugesund
    Norway
    Norwegian1336280001
    MACKIE, Grahame John Sinclair
    35 Hammersmith Road
    AB1 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    35 Hammersmith Road
    AB1 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    British676720001
    MELING, Jan Fredrik
    Naumdoelaveien 18
    FOREIGN Haugesund
    Norway
    Amministratore
    Naumdoelaveien 18
    FOREIGN Haugesund
    Norway
    Norwegian1336290001
    MIKAELSEN, Oeyvind
    Ragnh Ildsgate 48
    4044 Hafrsejord
    Norway
    Amministratore
    Ragnh Ildsgate 48
    4044 Hafrsejord
    Norway
    Norwegian91267430001
    OAKLEY, Stuart David
    Castleton House
    15 The Chanonry
    AB24 1RP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Castleton House
    15 The Chanonry
    AB24 1RP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    British38261820001
    SKOUVEROE, Jan Frithjof
    Lillevannsveien 12c
    FOREIGN 0390 Oslo 3
    Norway
    Amministratore
    Lillevannsveien 12c
    FOREIGN 0390 Oslo 3
    Norway
    Norwegian25049690001
    SMITH, David Russell
    Manor House
    Midmar
    AB51 7LX Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Manor House
    Midmar
    AB51 7LX Inverurie
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish20205140001
    SVENSON, Einar Wold
    3 Haraldskroken
    4041 Hafrsfjord
    Amministratore
    3 Haraldskroken
    4041 Hafrsfjord
    British1396780001
    VOSSIER, Bernard Lucien
    Bede House Court
    54 Don Street
    AB2 1UU Aberdeen
    Amministratore
    Bede House Court
    54 Don Street
    AB2 1UU Aberdeen
    French44196670001
    WEBSTER, Gary Roderick
    3 Bograxie Burnhervie
    AB51 5LD Inverurie
    Amministratore
    3 Bograxie Burnhervie
    AB51 5LD Inverurie
    ScotlandBritish1130100002
    WEBSTER, Gary Roderick
    3 Bograxie Burnhervie
    AB51 5LD Inverurie
    Amministratore
    3 Bograxie Burnhervie
    AB51 5LD Inverurie
    ScotlandBritish1130100002

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Integrated Safety Management Limited
    Oldmeldrum
    4
    AB51 0DG Inverurie
    Fisher Offshore Westbank Park
    Scotland
    06 apr 2016
    Oldmeldrum
    4
    AB51 0DG Inverurie
    Fisher Offshore Westbank Park
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2016
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (Scotland)
    Numero di registrazioneSc265296
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 giu 2014
    Consegnato il 19 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 19 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 lug 2014Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 17 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 14 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Tenants interest in 2.9 acres at 123 ashgrove road west, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 17 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 02 dic 2004
    Consegnato il 11 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 18 giu 2014Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 10 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 15 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Leasehold interest in 123 ashgrove road west, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 15 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground extending to 2.9 acres or thereby lying to the south-east of ashgrove road west, aberdeen.
    Persone aventi diritto
    • Seaway Technology Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 12 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Floating charge
    Creato il 21 gen 1991
    Consegnato il 04 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Seaway Technology LTD
    Transazioni
    • 04 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1992Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 12 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Bond & floating charge
    Creato il 24 ago 1990
    Consegnato il 29 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1992Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 13 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 16 lug 1990
    Consegnato il 27 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Loirston cottage cove bay nigg.
    Transazioni
    • 27 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 29 mag 1990
    Consegnato il 06 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Loirston cottage cove bay nigg.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 30 mar 1987
    Consegnato il 06 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of offset
    Creato il 19 mar 1987
    Consegnato il 27 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by seaway technology and another
    Brevi particolari
    Balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of stolt-nielsen seaway contracting limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    Bond & floating charge
    Creato il 19 mar 1987
    Consegnato il 27 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mar 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0