LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED

LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC059324
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2010

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG03s

    Cessazione della carica di Anne Woods come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christine Griffiths come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mar 2010

    Stato del capitale al 29 mar 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Anthony Karran il 17 mar 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Moira Thomson Mcharrie il 17 mar 2010

    3 pagineCH01

    Nomina di Anne Elizabeth Couper Woods come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Christine Martha Campbell Griffiths come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alistair Allan come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2007

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2006

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KARRAN, David Anthony
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Amministratore
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish146844090001
    MCHARRIE, Moira Thomson
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Amministratore
    Top Floor
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    C/O Simcocks Trust Limited
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish146827140001
    ALLAN, Alistair John
    94 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2SY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    94 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2SY Glasgow
    Lanarkshire
    British110042200001
    THOM, Robin
    113 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 5BT Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    113 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 5BT Glasgow
    Lanarkshire
    Scottish41503900002
    WISEMAN, William
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    British422620001
    BLACK, Ian Craig
    Church View 25 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AQ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Church View 25 Sywell Road
    Overstone
    NN6 0AQ Northampton
    Northamptonshire
    British4579780001
    CHALMERS, Norman Ashley
    Brook House
    Templewood Lane
    SL2 3HW Farnham Common
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Brook House
    Templewood Lane
    SL2 3HW Farnham Common
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish35542160001
    GREEN, Simon Charles
    2 Great Western Terrace Dowanhill
    G12 9NA Glasgow
    Amministratore
    2 Great Western Terrace Dowanhill
    G12 9NA Glasgow
    British44467640001
    GRIEVE, Alexander Raeburn
    Carlhurlie
    KY8 5QE Lundin Links
    Fife
    Amministratore
    Carlhurlie
    KY8 5QE Lundin Links
    Fife
    ScotlandScottish409950001
    GRIFFITHS, Christine Martha Campbell
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    Amministratore
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    UkBritish147842710001
    KELLY, Patrick Joseph
    2 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    2 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish71731770001
    LAWTHER, Samuel David
    Dean House
    Upper Dean
    PE18 0ND Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Dean House
    Upper Dean
    PE18 0ND Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460001
    LOW, Richard Dennis
    Hughenden House
    25 Hughenden Road
    G12 9XP Glasgow
    Amministratore
    Hughenden House
    25 Hughenden Road
    G12 9XP Glasgow
    United KingdomBritish47115610003
    MCINTYRE, John
    The White House Of Milliken
    PA5 8 Brookfield
    Amministratore
    The White House Of Milliken
    PA5 8 Brookfield
    ScotlandBritish422630001
    RUDGE, Alan James
    Packwood Manor Road
    Grendon
    NN7 1JF Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Packwood Manor Road
    Grendon
    NN7 1JF Northampton
    Northamptonshire
    British9647250001
    STEVENSON, Peter David
    The White House
    147 Whitehouse Lane
    EH9 2EY Edinburgh
    Amministratore
    The White House
    147 Whitehouse Lane
    EH9 2EY Edinburgh
    ScotlandBritish1251400001
    SWANSON, John George
    14 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    14 Crosslees Road
    Thornliebank
    G46 7EW Glasgow
    Lanarkshire
    British409920001
    WILSON, Gordon Scott Macintyre
    2 Brierie Lane
    Brierie Hills
    PA6 7LS Crossley
    Houston
    Amministratore
    2 Brierie Lane
    Brierie Hills
    PA6 7LS Crossley
    Houston
    United KingdomBritish32664250002
    WILSON, Lynn Anthony
    The Maltings Tithe Farm
    Moulton Road Holcot
    NN6 9SH Northampton
    Amministratore
    The Maltings Tithe Farm
    Moulton Road Holcot
    NN6 9SH Northampton
    British92355200002
    WISEMAN, William
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    58 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish422620001
    WOODS, Anne Elizabeth Couper
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    Amministratore
    c/o Simcocks Trust Limited
    14 Athol Street
    IM1 1JA Douglas
    Top Floor
    Isle Of Man
    UkBritish147842400001

    LONDON & CLYDESIDE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 30 ott 1998
    Consegnato il 12 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 28 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere fluttuante (MG03s)
    Standard security
    Creato il 30 ago 1995
    Consegnato il 15 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects situated at darnley mains estate, nitshill road, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 ago 1995
    Consegnato il 15 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    955 shettleston road, glasgow, registered under title number gla 57683.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 30 ago 1995
    Consegnato il 15 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    410 to 414 (even numbers) hillington road, glasgow, registered under title number gla 34663.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 29 ago 1995
    Consegnato il 01 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 set 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 08 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 24 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    The whole obligations in terms of missives dated 31/3/95
    Brevi particolari
    Gla 96302.
    Persone aventi diritto
    • B & Q PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (410)
    Standard security
    Creato il 28 gen 1994
    Consegnato il 09 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Subjects on south west side of nitshill road darnley glasgow-GLA26727.
    Persone aventi diritto
    • Seagram United Kingdom Limited
    Transazioni
    • 09 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 21 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 04 giu 1993
    Consegnato il 11 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    955 shettleston road, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 01 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 gen 1991
    Consegnato il 11 gen 1991
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    955 shettleston road glasgow gla 57683.
    Persone aventi diritto
    • Municipal General Insurance Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 29 dic 1989
    Consegnato il 15 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    1.54 acres west of stenhouse road,falkirk.
    Persone aventi diritto
    • Scarborough and Glasgow Property Company Limited
    Transazioni
    • 15 gen 1990Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 nov 1989
    Consegnato il 12 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    16.24 acres west of stenhouse road,falkirk.
    Persone aventi diritto
    • Scarborough and Glasgow Property Company Limited
    Transazioni
    • 12 dic 1989Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creato il 05 apr 1989
    Consegnato il 10 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    The whole assets of the company.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1994Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 08 giu 1995Modifica di un'ipoteca flottante (466 Scot)
    • 05 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • Ha modifiche all'ordine:
    Standard security
    Creato il 29 gen 1988
    Consegnato il 05 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Bridgeton cross shopping centre, main st, bridgeton.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 08 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Bridgeton cross shopping centre, main street, bridgeton.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 15 dic 1986
    Consegnato il 31 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease over 4608 sq. Metres or thereby bounded on or towards the north north west by the south south east side of the carriageway and footpath of james street, bridgeton glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Municipal Mutual Insurance LTD
    Transazioni
    • 31 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 31 ott 1984
    Consegnato il 19 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Lease by city of glasgow district council.
    Persone aventi diritto
    • Balfour Beatty Construction (Scotland) LTD
    Transazioni
    • 19 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 11 feb 1981
    Consegnato il 23 feb 1981
    In corso
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Area of ground lying on the south side of maclellan street, glasgow extending to 5.03 acres.
    Persone aventi diritto
    • St. Martins Property Investments LTD, St. Vedast House, 150 Cheapside, London
    Transazioni
    • 23 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    • 19 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)
    Standard security
    Creato il 28 gen 1981
    Consegnato il 11 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Elliot street,glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1981Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 07 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (419a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0