CAPE CLADDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CAPE CLADDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC063029 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAPE CLADDINGS LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova CAPE CLADDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | KPMG RESTRUCTURING Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAPE CLADDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
J & R AITKEN (JOINERS) LIMITED | 06 set 1977 | 06 set 1977 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAPE CLADDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per CAPE CLADDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Nancye Amey come amministratore in data 08 mar 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Verbale della riunione finale di liquidazione volontaria | 3 pagine | 4.26(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Blythswood Square Glasgow G2 4AD in data 09 ott 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Domanda di insolvenza INSOLVENCY:Form 600 Notice of Appointment of Liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Christopher Francis Judd come segretario in data 23 mag 2012 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeremy Philip Gorman come segretario in data 23 mag 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucy Turner come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Jeremy Philip Gorman come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 01 dic 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 16 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Lucy Finch Turner il 23 dic 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Anne George il 18 dic 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 18 dic 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 1 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAPE CLADDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDD, Christopher Francis | Segretario | Millenia Tower One Temasek Avenue 039192 Singapore #09-03 Singapore | 169521610001 | |||||||
GEORGE, Victoria Anne | Amministratore | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Tax Adviser | 134024500001 | ||||
CRAIGIE, Claire Louise | Segretario | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830001 | |||||
GORMAN, Jeremy Philip | Segretario | 2 Blythswood Square Glasgow G2 4AD | 160675450001 | |||||||
PITT-PAYNE, Michael George | Segretario | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 829660002 | ||||||
RHODES, Jeremy | Segretario | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||
SMITH, Stephen Harry | Segretario | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||
TURNER, Lucy Finch | Segretario | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Segretario | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | Solicitor | 99402260002 | |||||
AMEY, Rachel Nancye | Amministratore | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 133976650005 | ||||
ASHCROFT, Anthony | Amministratore | The Long House Great Addington NN14 4BA Kettering Northamptonshire | British | Company Director | 31111580001 | |||||
BINGHAM, Richard Keith | Amministratore | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | Accountant | 131046090001 | |||||
CARTWRIGHT, Paul Ian | Amministratore | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | Chartered Accountant | 40873830002 | |||||
CRAIGIE, Claire Louise | Amministratore | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830001 | |||||
FARRELL, John Patrick | Amministratore | Broadcroft Little Hallingbury CM22 7RT Bishops Stortford Herts | United Kingdom | British | Company Director | 702300001 | ||||
GILLESPIE, Andrew James | Amministratore | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 89560440001 | ||||
HOPWOOD, Geoffrey Alan | Amministratore | 22 Blackpot Lane Oundle Peterborough | British | Company Director | 829710001 | |||||
JACKSON, Francis Keith John | Amministratore | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | Director | 15469790001 | ||||
MCKAIN, Thomas Morrison | Amministratore | Horseshoe Ridge St George's Hill Weybridge Surrey | British | Company Director | 829670001 | |||||
MOSCROP, Anthony | Amministratore | 17 Brook Court Horton NN7 2BL Northampton Northamptonshire | British | Company Director | 829680001 | |||||
PITT-PAYNE, Michael George | Amministratore | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 829660002 | ||||
SMITH, Stephen Harry | Amministratore | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||
SPARKES, John Leslie | Amministratore | High House Bell Hill Lamarsh CO8 5EP Bures Suffolk | United Kingdom | British | 1291070001 | |||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Amministratore | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | Solicitor | 99402260002 | ||||
WIDDOWSON, Ian Richard | Amministratore | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 16941000001 | |||||
CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
CAPE CLADDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Creato il 20 lug 2001 Consegnato il 03 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Legal mortgage over all real property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 18 lug 2001 Consegnato il 03 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 27 nov 1985 Consegnato il 17 dic 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 15 ott 1985 Consegnato il 21 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due by the company and others | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All securities or other property of the company held by any of the banks whether for safe custody or otherwise. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All rights, moneys or property accruing, all stocks, shares and other securities belonging to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Any financial obligation to or any sum held, received or receivable on behalf of the company by any of the banks. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All book debts and other debts due or owing to the company at the date of debenture. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Present and future goodwill of the company and the benefit of any licences, trade marks, copyrights, designs and other intellectual property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari All estates or interests in any freehold and leasehold property together with all fixtures and fittings. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CAPE CLADDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0