MICROCENTRE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MICROCENTRE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | SC066117 |
| Giurisdizione | Scozia |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MICROCENTRE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MICROCENTRE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MICROCENTRE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MICRO CENTRE (COMPLETE MICRO SYSTEMS) LIMITED | 23 ott 1978 | 23 ott 1978 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MICROCENTRE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MICROCENTRE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Conto finale prima della dissoluzione in MVL (conto finale allegato) | 6 pagine | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Centrum Business Centre Suite No. 4a 38 Queen Street Glasgow G1 3DX Scotland a 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG in data 18 apr 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Northgate Mill Road Industrial Estate Linlithgow West Lothian EH49 7SF a The Centrum Business Centre Suite No. 4a 38 Queen Street Glasgow G1 3DX in data 29 gen 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di David John Meaden come amministratore in data 22 dic 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Andrew Coll come amministratore in data 22 dic 2014 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Robert Stier come amministratore in data 22 dic 2014 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Daniel William Schenck come segretario in data 22 dic 2014 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MICROCENTRE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| MCDONNELL, James | Segretario | 2 Carwood Crescent BT36 5LT Glengormley County Antrim N.Ireland | British | 143194930001 | ||||||||||
| NUNN, Carol Jayne | Segretario | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Segretario | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | British | 128558470001 | ||||||||||
| ROBERTSON, Michael Andrew | Segretario | 2 Robins Wood CA3 9FN Carlisle Cumbria | British | 75632700001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Segretario | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| THOM, Ian | Segretario | Copsewood 60 Drumbo Road BT27 5TX Lisburn Antrim | British | 156536170001 | ||||||||||
| TURNBULL, James Douglas | Segretario | Inverallan 62 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | British | 538440004 | ||||||||||
| WISHART, Doreen Pamela Craig | Segretario | 16 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 98700001 | ||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Amministratore | Mill Road Industrial Estate EH49 7SF Linlithgow C/O Northgate West Lothian | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| BAILES, Robert | Amministratore | 4 Cambridge Avenue BT42 2EN Ballymena County Antrim | British | 71052640001 | ||||||||||
| BRADY, Richard Noel | Amministratore | Scrabo Lodge, 179-181 Scrabo Road BT23 4SJ Newtownards County Down | Northern Ireland | British | 142958140001 | |||||||||
| COLL, Andrew | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| CREIGHTON, Steven Henry | Amministratore | 4 Croft Meadows BT18 0LB Holywood County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 143021640001 | |||||||||
| GREGG, Norman Campbell Minnis | Amministratore | 1 Brooklands Park BT23 4XY Newtownards County Down | Northern Ireland | British | 71052540001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Grace | Amministratore | 6 Grosvenor Crescent Hillhead G12 9AE Glasgow | British | 48366920003 | ||||||||||
| MCCANN, Robert | Amministratore | 3 Green Acres BT36 6NL Newtownabbey County Antrim | British | 71196070001 | ||||||||||
| MEADEN, David John | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NEVILLE, Geoffrey Leslie | Amministratore | 53 Church Road Abbots Leigh BS8 3QU Bristol Avon | United Kingdom | British | 39989270002 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| PRINGLE, Aileen | Amministratore | 12 Belgrave Crescent EH4 3AH Edinburgh | United Kingdom | British | 764870001 | |||||||||
| PRINGLE, Ann Isobel | Amministratore | 5 Royal Drive ML3 7DJ Hamilton Lanarkshire | British | 538430002 | ||||||||||
| PRINGLE, John Stock | Amministratore | Upper Carbarns Farm Netherton ML2 0RW Wishaw | British | 355710003 | ||||||||||
| ROBERTSON, Michael Andrew | Amministratore | 2 Robins Wood CA3 9FN Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | 75632700001 | |||||||||
| ROUXEL, Norman Hugh | Amministratore | 37 Scotland Street EH3 6PY Edinburgh Midlothian | British | 349250001 | ||||||||||
| STIER, John Robert | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| TURNBULL, James Douglas | Amministratore | Inverallan 62 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | British | 538440004 | ||||||||||
| WISHART, David | Amministratore | 16 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 98690001 | |||||||||
| WISHART, Doreen Pamela Craig | Amministratore | 16 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 98700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MICROCENTRE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northgate Public Services (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MICROCENTRE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creato il 26 mar 1998 Consegnato il 31 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 20 sandyford place,glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 07 ago 1979 Consegnato il 15 ago 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MICROCENTRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0