TAYBURN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAYBURN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società SC067241
    GiurisdizioneScozia
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAYBURN LIMITED?

    • Attività di design specializzato (74100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TAYBURN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Scotland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TAYBURN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TAYBURN DESIGN LIMITED14 lug 198914 lug 1989
    TAYBURN LIMITED05 mar 197905 mar 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAYBURN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per TAYBURN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Steven Watson Clark come segretario in data 25 apr 2024

    1 pagineTM02

    Nomina di David Ross Lewis come amministratore in data 25 apr 2024

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2023, non revisionato

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022

    12 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 15 Kittle Yards Causewayside Edinburgh EH9 1PJ a 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA in data 29 set 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Malcolm Neil Stewart il 01 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard David Simpson il 01 mar 2020

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di TAYBURN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, David Ross
    Vicar Street
    FK1 1LL Falkirk
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Vicar Street
    FK1 1LL Falkirk
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector323760240001
    SIMPSON, Richard David
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    Amministratore
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    ScotlandBritishBusiness Development Director140467110002
    STEWART, Malcolm Neil
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    Amministratore
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    ScotlandBritishCreative Director79120080003
    CARRUTHERS, Lynn Duncan
    8 Blackwood Green
    Pitreavie Castle
    KY11 8QG Dunfermline
    Segretario
    8 Blackwood Green
    Pitreavie Castle
    KY11 8QG Dunfermline
    BritishAccountant47631880004
    CLARK, Steven Watson
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    Segretario
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    1 Lochrin Square
    Scotland
    186532430001
    DAVIDSON, William Dow
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Segretario
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    British815790001
    DAVIDSON, William Dow
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Segretario
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    British815790001
    MONTGOMERY, Sheila Ann
    12 Pumpherston Road
    Mid Calder
    EH53 0AY Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Segretario
    12 Pumpherston Road
    Mid Calder
    EH53 0AY Livingston
    West Lothian
    Scotland
    BritishChartered Accountant5026880001
    BROWN, Alastair Neil Grant
    2 Queens Crescent
    EH9 2AZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    2 Queens Crescent
    EH9 2AZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishBusiness Director194090001
    CADBURY, Nicholas Andrew
    46 Swanston Avenue
    EH10 7BZ Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    46 Swanston Avenue
    EH10 7BZ Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritishDesign Director79122770001
    CASSIDY, Kenneth Vincent
    19a Hazel Avenue
    G66 4RR Lenzie
    Amministratore
    19a Hazel Avenue
    G66 4RR Lenzie
    UkBritishDirector92741650001
    DAVIDSON, Erick
    25a Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    25a Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishCompany Director26100001
    DAVIDSON, William Dow
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    42 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritishChartered Accountant815790001
    ERDAL, David Edward
    West Court
    Hepburn Gardens
    KY16 9LN St Andrews
    Fife
    Amministratore
    West Court
    Hepburn Gardens
    KY16 9LN St Andrews
    Fife
    United KingdomBritishCompany Director8000001
    FARRELL, Simon Wilson
    39 Clermiston Road
    Corstorphine
    EH12 6XD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    39 Clermiston Road
    Corstorphine
    EH12 6XD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director106463780002
    FORTUNE-SMITH, Gary James
    Drumcrannog
    3b Trinity Park
    TD11 3HN Duns
    Berwickshire
    Amministratore
    Drumcrannog
    3b Trinity Park
    TD11 3HN Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritishTechnical Director99342170001
    GIBSON, Archibald Turner
    Gowrie
    8 Succoth Avenue
    EH12 6BT Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    Gowrie
    8 Succoth Avenue
    EH12 6BT Edinburgh
    Midlothian
    BritishRetired Banker120070001
    HAIN, Ronald Baird
    7 Bishop Terrace
    Kinnesswood
    KY13 7JW Kinross
    Fife
    Amministratore
    7 Bishop Terrace
    Kinnesswood
    KY13 7JW Kinross
    Fife
    BritishCompany Director338520001
    HODGSON, Robert James
    The Hunting Lodge
    Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    The Hunting Lodge
    Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director54501880002
    HUNTER, Andrew
    Kinloch House 1 Market Street
    EH41 3JL Haddington
    East Lothian
    Amministratore
    Kinloch House 1 Market Street
    EH41 3JL Haddington
    East Lothian
    BritishDesigner559720001
    LAIRD, Campbell Doull
    6 Havens Edge
    KY11 3LJ Limekilns
    Fife
    Amministratore
    6 Havens Edge
    KY11 3LJ Limekilns
    Fife
    ScotlandBritishBusiness Director46830610001
    MCCOLL, Alexander Brendan
    27 Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    27 Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director338510001
    MITCHELL, Steven
    33 Northumberland Street
    EH3 6LR Edinburgh
    Amministratore
    33 Northumberland Street
    EH3 6LR Edinburgh
    ScotlandBritishCompany Director40722030002
    NICOLSON, David
    Cluan House
    Dunira
    PH6 2JY Comrie
    Perthshire
    Amministratore
    Cluan House
    Dunira
    PH6 2JY Comrie
    Perthshire
    ScotlandBritishChartered Accountant84155610001
    NORRIS, Simon
    4 Orchard Terrace
    EH4 2HA Edinburgh
    Amministratore
    4 Orchard Terrace
    EH4 2HA Edinburgh
    BritishCompany Director338530004
    RUSSELL, Graham Lamont
    17a Morningside Road
    EH10 4DP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    17a Morningside Road
    EH10 4DP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDesigner338550001
    SCOTT, Andrew Neale
    12 Highbury Hill
    N5 1AL London
    Amministratore
    12 Highbury Hill
    N5 1AL London
    BritishCompany Director65030230001
    SKAKEL, Andrew Douglas
    Beech House
    Main Street
    EH35 5HT Ormiston
    East Lothian
    Amministratore
    Beech House
    Main Street
    EH35 5HT Ormiston
    East Lothian
    BritishDesigner38648260001
    SKAKEL, Richard
    10 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    Amministratore
    10 Forres Street
    EH3 6BJ Edinburgh
    BritishProjects Director44679350001
    SLATER, John
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director338270001
    SMITH, Kay Edwina
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    43 Dublin Street
    EH3 6NL Edinburgh
    Midlothian
    BritishDesigner338540001
    WHITEHORN, William Elliott
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    Amministratore
    31 Dents Road
    SW11 6JA London
    United KingdomBritishCompany Director46878420002
    WOLFFE, Andrew John Antony
    3 Lennox St Lane
    EH4 1PZ Edinburgh
    Amministratore
    3 Lennox St Lane
    EH4 1PZ Edinburgh
    ScottishDesigner8985620004

    Chi sono le persone con controllo significativo di TAYBURN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Tayburn Holdings Ltd
    Kittle Yards
    EH9 1PJ Edinburgh
    15
    Scotland
    06 apr 2016
    Kittle Yards
    EH9 1PJ Edinburgh
    15
    Scotland
    No
    Forma giuridicaTayburn Holdings Ltd
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneScotland
    Numero di registrazioneSc112753
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TAYBURN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Bond & floating charge
    Creato il 01 ott 2003
    Consegnato il 07 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (410)
    • 24 mag 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of offset
    Creato il 06 nov 1987
    Consegnato il 19 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by tayburn design group LTD and/or others
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of offset
    Creato il 17 apr 1985
    Consegnato il 01 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due, or to become due by tayburn interior design LTD
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter of offset
    Creato il 07 giu 1983
    Consegnato il 16 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due by cockburn taylor holdings LTD and/or others
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts of any accounts held by the bank of scotland in name of tayburn LTD.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Bond & floating charge
    Creato il 11 mag 1979
    Consegnato il 23 mag 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 mag 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0