MERPRO GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | MERPRO GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | SC067714 |
Giurisdizione | Scozia |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MERPRO GROUP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MERPRO GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | National Oilwell Varco Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen Aberdeenshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MERPRO GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MERPRO LIMITED | 27 apr 1979 | 27 apr 1979 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MERPRO GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per MERPRO GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | AC93 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomina di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 31 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Scott Reid come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alastair James Fleming come amministratore in data 31 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Scott Reid come amministratore in data 09 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Paul O'neil come amministratore in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robbert Oudendijk come amministratore in data 30 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Christopher Paul O'neil il 22 lug 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MERPRO GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOAN, Alison May | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
O'NEIL, Christopher Paul | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | United Kingdom | British | Vp Finance | 162062160001 | ||||
OUDENDIJK, Robbert | Amministratore | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | Vice President Finance Europe, Mena, Cis | 201609020001 | ||||
FIDDES, Carole | Segretario | 88 Castle Street DD10 8AG Montrose | British | 82920570002 | ||||||
FLEMING, Alastair James | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163563190001 | |||||||
GALLACHER, Kevin Terence, Mr. | Segretario | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | British | 71782100001 | ||||||
GALLACHER, Kevin Terence, Mr. | Segretario | 38 Loraine Road DD4 7DZ Dundee Angus | British | 71782100001 | ||||||
O'NEIL, Christopher | Segretario | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire U.K. | British | 159904500001 | ||||||
TAYLOR, Colin Harwood | Segretario | Powis House Barnhead DD10 9LL Montrose Angus | British | 1340290001 | ||||||
ADAMS, John Edward | Amministratore | Braehead, Kirkton St.Cyrus DD10 0BW Montrose Angus | Scotland | British | Engineer | 988200001 | ||||
ADAMS, Margaret | Amministratore | Braehead, Kirkton St Cyrus DD10 0BW Montrose Angus | British | Company Director | 9495940001 | |||||
BOYLE, Thomas Douglas | Amministratore | Old Inn Road, Findon Portlethen AB12 3RT Aberdeen Lanark U.K. | Uk | British | Vp Finance Europe | 61611910001 | ||||
FLEMING, Alastair James | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | Uk Country Controller | 180854890001 | ||||
FUDGE, Sydney Robert | Amministratore | Brent Avenue DD10 9PB Montrose Merpro Angus United Kingdom | Scotland | British | Director | 10630480001 | ||||
GALLACHER, Kevin Terence, Mr. | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | Accountant | 71782100001 | ||||
KEENER, David James | Amministratore | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | Company Director | 161469350001 | ||||
MURRAY, Michael Alexander | Amministratore | 2 Palmerston Street DD10 8HR Montrose Angus | British | Engineer | 988800001 | |||||
O'NEIL, Christopher Paul | Amministratore | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | Vp Finance | 162062160001 | ||||
PARKINSON, David John | Amministratore | Arodene Walton Down BS21 7AR Walton In Gordano North Somerset | England | British | Engineer | 160406000001 | ||||
REID, Simon Scott | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | Accountant | 248254430001 | ||||
SMITH, David Robert, Mr. | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | It Systems Administrator | 124662860001 | ||||
SMITH, Jennifer Margaret | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | Consultant | 124662820001 | ||||
SMITH, Margaret | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | Company Director | 9495950001 | ||||
SMITH, Robert Melville, Mr. | Amministratore | Badentoy Crescent, Badentoy Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen National Oilwell Varco Aberdeenshire | Scotland | British | Engineer | 353890001 | ||||
TAYLOR, Colin Harwood | Amministratore | Powis House Barnhead DD10 9LL Montrose Angus | British | Chartered Accountant | 1340290001 | |||||
VALENTINE, Steven Grenville | Amministratore | Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe 4 | England | British | Financial Controller | 92773870002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MERPRO GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Oilwell Varco Uk Limited | 06 apr 2016 | Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MERPRO GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Standard security | Creato il 17 giu 1992 Consegnato il 01 lug 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari The building and ground comprising the former angus workwear premises, forties road, montrose, angus. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 06 mar 1985 Consegnato il 11 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1.06 hectare at brent avenue, montrose, angus with factory, office building and other erections thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 06 mar 1985 Consegnato il 13 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari 1.06 hectare at brent avenue, montrose, angus with factory, office building and other erection. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 27 feb 1985 Consegnato il 07 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 11 apr 1984 Consegnato il 30 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground extending to 908 1/1000TH parts of a hectare and second plot extending 87 1/1000TH parts of a hectare in montrose, angus. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 11 apr 1984 Consegnato il 18 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Ground extending to 908 1/1000TH parts of a hectare known as brent avenue, montrose in angus. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 22 dic 1983 Consegnato il 06 gen 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards the west of forties road montrose. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 08 dic 1983 Consegnato il 23 dic 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Standard security | Creato il 05 feb 1982 Consegnato il 12 feb 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Plot of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards forties road montrose. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security | Creato il 05 feb 1982 Consegnato il 19 feb 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Area of ground in angus extending to 2 acres lying on or towards forties road, montrose. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 08 dic 1981 Consegnato il 17 dic 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Creato il 17 giu 1980 Consegnato il 26 giu 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0